MITRE SECRETARIES LIMITED - Pagina 24
Dirigente societario
Nome | MITRE SECRETARIES LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 3 |
Inattivo | 136 |
Dimesso | 767 |
Totale | 906 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
ANGEL TRAINS CONSULTING LIMITED | 17 mar 1997 | 09 mag 1997 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ROSANTO PHARMACEUTICALS LTD | 21 feb 1997 | 01 apr 1997 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ANGEL TRAIN CONTRACTS LIMITED | 17 mar 1997 | 27 mar 1997 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SPENCER PRIVATE HOSPITALS LIMITED | 23 nov 1995 | 13 mar 1997 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BOURN ESTATES LIMITED | 17 feb 1997 | 12 mar 1997 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SICAME UK LIMITED | 17 feb 1997 | 07 mar 1997 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CABLE REALISATIONS LIMITED | 27 dic 1996 | 07 mar 1997 | Liquidazione | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SHUKCO 327 LTD | 25 nov 1996 | 04 mar 1997 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
UNITED WASTE PROPERTY LIMITED | 25 nov 1996 | 04 mar 1997 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
IPT EMPLOYEE BENEFIT TRUSTEES LIMITED | 25 nov 1996 | 31 gen 1997 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
JACQUES VERT BRANDS LIMITED | 30 ott 1996 | 08 gen 1997 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BIFFA (UK) HOLDINGS LIMITED | 12 set 1996 | 24 dic 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
R S M B AUDIENCE RESEARCH LTD | 21 ott 1996 | 06 dic 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
UNIVET LIMITED | 15 ago 1996 | 23 ott 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
DOCKSIDE DEVELOPMENTS LIMITED | 13 ago 1996 | 08 ott 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
PADENOME LIMITED | 12 feb 1996 | 25 set 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CYCLACEL LIMITED | 13 ago 1996 | 10 set 1996 | Liquidazione | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SERVISAIR (CONTRACT HANDLING) LIMITED | 05 ago 1996 | 30 ago 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 05 ago 1996 | 22 ago 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
NICKELODEON INTERNATIONAL LIMITED | 30 lug 1996 | 22 ago 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
RADIUS PENSION TRUSTEES LIMITED | 17 giu 1996 | 08 ago 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ORBICHEM LIMITED | 05 ago 1996 | 07 ago 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
HEATHROW CARGO HANDLING LIMITED | 05 lug 1995 | 12 lug 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ST GEORGE REAL ESTATE LIMITED | 04 mar 1996 | 18 giu 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
OLDCO LIMITED | 04 mar 1996 | 17 mag 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
VOSPER-MANTECH LIMITED | 09 mar 1995 | 11 apr 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ABACUS POLAR LIMITED | 27 ott 1995 | 03 apr 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
LGC LIMITED | 18 nov 1994 | 28 mar 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
TRL LIMITED | 29 dic 1995 | 25 mar 1996 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
WALKERS SNACK SERVICES LIMITED | 31 ago 1995 | 15 mar 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ELGA GROUP SERVICES LIMITED | 12 feb 1996 | 13 mar 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
J T DESIGN BUILD LIMITED | 09 mar 1995 | 09 mar 1996 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BABCOCK WEST SUSSEX CAREERS LIMITED | 23 nov 1995 | 18 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
IBC FOURTEEN LIMITED | 27 ott 1995 | 15 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BABCOCK SOUTHERN CAREERS LIMITED | 09 gen 1995 | 13 dic 1995 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0