LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED

LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaLINK HOUSE MAGAZINES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01341560
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    6th Floor 60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LINK HOUSE MAGAZINES (CROYDON) LIMITED01/12/197701/12/1977

    Quais são as últimas contas de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2017

    Quais são as últimas submissões para LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 30/05/2019 com atualizações

    4 páginasCS01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2018 para 30/06/2019

    1 páginasAA01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    3 páginasAA

    O processo de dissolução compulsória foi descontinuado

    1 páginasDISS40

    Declaração de confirmação apresentada em 30/05/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Endereço do domicílio registado alterado de Room 3-C29 Blue Fin Building 110 Southwark Street London SE1 0SU England para 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR em 20/08/2018

    1 páginasAD01

    Alteração dos detalhes de Lh Media Limited como pessoa com controlo significativo em 20/08/2018

    2 páginasPSC05

    Término da nomeação de Stephen John May como diretor em 13/03/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephen John May como diretor em 13/03/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Marcus Alvin Rich como diretor em 13/03/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Susana D'emic como diretor em 31/01/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr John Stanley Zieser como diretor em 15/02/2018

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Joseph Henry Ceryanec como diretor em 15/02/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Lauren Ezrol Klein como secretário em 31/01/2018

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 30/05/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Nomeação de Susana D'emic como diretor em 07/11/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Jeffrey John Bairstow como diretor em 07/11/2016

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    3 páginasAA

    Término da nomeação de Charles Lloyd Meredith como diretor em 31/05/2016

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 30/05/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital07/06/2016

    Estado do capital em 07/06/2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Quem são os diretores de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CERYANEC, Joseph Henry
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Diretor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    United StatesAmerican243478830001
    ZIESER, John Stanley
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Diretor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    United StatesAmerican243480710001
    DAVIES, John Graeme
    The Coach House Ghyll Head
    Waterhead
    LA22 0HD Ambleside
    Cumbria
    Secretário
    The Coach House Ghyll Head
    Waterhead
    LA22 0HD Ambleside
    Cumbria
    British72253030001
    GORE, John Francis
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Secretário
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British352680001
    KLEIN, Lauren Ezrol
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    Secretário
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    British127397780001
    MCCARTHY, Robert
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    Secretário
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    British78644500001
    PEDEN, Michael Timothy
    West Gate 38 Worgret Road
    BH20 4PN Wareham
    Dorset
    Secretário
    West Gate 38 Worgret Road
    BH20 4PN Wareham
    Dorset
    British46871090001
    PYPER, Richard John
    24 Bourne Close
    EN10 7NE Broxbourne
    Hertfordshire
    Secretário
    24 Bourne Close
    EN10 7NE Broxbourne
    Hertfordshire
    British74495760001
    REDPATH, John
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    Secretário
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    British88622150001
    WILLIAMS, Sally Jane
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Secretário
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    British3660830002
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Diretor
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    ATKINSON, Richard Gordon
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Diretor
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    British78644420001
    AUTON, Sylvia Jean
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    Diretor
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59045280002
    AVERILL, Howard
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    Diretor
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    UsaUsa127283350001
    BAILEY, Sylvia
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    Diretor
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    British67232740001
    BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr.
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Diretor
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    UsaAmerican181954550002
    BROWNING, David John Walter
    2 Roman Walk
    BR2 8QN Bromley
    Kent
    Diretor
    2 Roman Walk
    BR2 8QN Bromley
    Kent
    British22103090001
    CAMERON, Andrew
    6 Sandy Lodge Road
    WD3 1LJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    6 Sandy Lodge Road
    WD3 1LJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    HertfordshireBritish109533650001
    COSGROVE, Peter John
    21 Kelsey Way
    BR3 3LP Beckenham
    Kent
    Diretor
    21 Kelsey Way
    BR3 3LP Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish580050001
    D'EMIC, Susana Alves
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Diretor
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    United StatesAmerican265525580001
    DOWNING, Brian George Kirby
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    Diretor
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    British8426380001
    EVANS, Richard John
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    Diretor
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish77303490001
    EVANS, Sylvia Kathleen
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    Diretor
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    United KingdomNew Zealander70941240001
    GAMM, Colin Keith
    23 Northampton Road
    CR0 7HB Croydon
    Surrey
    Diretor
    23 Northampton Road
    CR0 7HB Croydon
    Surrey
    British580060001
    HAMPEL, Paul Leonard
    13 Pottery Lane
    CM1 4HH Chelmsford
    Essex
    Diretor
    13 Pottery Lane
    CM1 4HH Chelmsford
    Essex
    British57201570001
    HAMPEL, Paul Leonard
    13 Pottery Lane
    CM1 4HH Chelmsford
    Essex
    Diretor
    13 Pottery Lane
    CM1 4HH Chelmsford
    Essex
    British57201570001
    JAKES, Clifford Duncan
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    Diretor
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    British8426370001
    MAIR, Denise Margaret
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    Diretor
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    United KingdomBritish99076200001
    MATTHEW, Michael
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    Diretor
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    British40092920001
    MAY, Stephen John
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Diretor
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    United KingdomBritish173367920001
    MEREDITH, Charles Lloyd
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Diretor
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    EnglandBritish189455000001
    MORGAN, Alan Ronald George
    11 Wavell Court Elgin Road
    CR0 6XB Croydon
    Diretor
    11 Wavell Court Elgin Road
    CR0 6XB Croydon
    British46480460001
    PYPER, Richard John
    24 Bourne Close
    EN10 7NE Broxbourne
    Hertfordshire
    Diretor
    24 Bourne Close
    EN10 7NE Broxbourne
    Hertfordshire
    British74495760001
    RICH, Marcus Alvin
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Diretor
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    EnglandBritish185688190001
    ROSEN, Howard Norman
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Diretor
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    UsaUsa111282190001

    Quem são as pessoas com controle significativo de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    06/04/2016
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom (England)
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro03028809
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 13/08/1999
    Entregue em 02/09/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    Link house 9 dingwall avenue croydon offices and 36 parking spaces; 23-25A george street croydon surrey studio offices workshops storage and 8 parking spaces; 583 fulham road london SW6 office and 2 parking spaces .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/09/1999Registro de uma garantia (395)
    • 18/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of amendment amending a deed of accession between the chargor, ipc magazines (UK) limited and the security agent supplemental to the debenture dated 19TH january 1998 as supplemented and amended on 22ND april 1998 and 12TH october 1998
    Criado em 22/12/1998
    Entregue em 06/01/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future monies and liabilities of the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/01/1999Registro de uma garantia (395)
    • 18/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of accession supplemental to the debenture and the debenture
    Criado em 12/10/1998
    Entregue em 15/10/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 15/10/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/03/1995
    Entregue em 08/04/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 08/04/1995Registro de uma garantia (395)
    • 16/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0