LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01341560 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| LINK HOUSE MAGAZINES (CROYDON) LIMITED | 01/12/1977 | 01/12/1977 |
Quais são as últimas contas de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/05/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2018 para 30/06/2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/05/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Room 3-C29 Blue Fin Building 110 Southwark Street London SE1 0SU England para 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR em 20/08/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Lh Media Limited como pessoa com controlo significativo em 20/08/2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Término da nomeação de Stephen John May como diretor em 13/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Stephen John May como diretor em 13/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Marcus Alvin Rich como diretor em 13/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Susana D'emic como diretor em 31/01/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr John Stanley Zieser como diretor em 15/02/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Joseph Henry Ceryanec como diretor em 15/02/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Lauren Ezrol Klein como secretário em 31/01/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 30/05/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Susana D'emic como diretor em 07/11/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jeffrey John Bairstow como diretor em 07/11/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Charles Lloyd Meredith como diretor em 31/05/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 30/05/2016 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Quem são os diretores de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERYANEC, Joseph Henry | Diretor | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United States | American | 243478830001 | |||||
| ZIESER, John Stanley | Diretor | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United States | American | 243480710001 | |||||
| DAVIES, John Graeme | Secretário | The Coach House Ghyll Head Waterhead LA22 0HD Ambleside Cumbria | British | 72253030001 | ||||||
| GORE, John Francis | Secretário | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Secretário | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Secretário | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| PEDEN, Michael Timothy | Secretário | West Gate 38 Worgret Road BH20 4PN Wareham Dorset | British | 46871090001 | ||||||
| PYPER, Richard John | Secretário | 24 Bourne Close EN10 7NE Broxbourne Hertfordshire | British | 74495760001 | ||||||
| REDPATH, John | Secretário | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Secretário | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| ALEY, William Robert | Diretor | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Diretor | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Diretor | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Diretor | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Diretor | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| BROWNING, David John Walter | Diretor | 2 Roman Walk BR2 8QN Bromley Kent | British | 22103090001 | ||||||
| CAMERON, Andrew | Diretor | 6 Sandy Lodge Road WD3 1LJ Rickmansworth Hertfordshire | Hertfordshire | British | 109533650001 | |||||
| COSGROVE, Peter John | Diretor | 21 Kelsey Way BR3 3LP Beckenham Kent | United Kingdom | British | 580050001 | |||||
| D'EMIC, Susana Alves | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | United States | American | 265525580001 | |||||
| DOWNING, Brian George Kirby | Diretor | 35 Badingham Drive Fetcham KT22 9EU Leatherhead Surrey | British | 8426380001 | ||||||
| EVANS, Richard John | Diretor | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Diretor | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| GAMM, Colin Keith | Diretor | 23 Northampton Road CR0 7HB Croydon Surrey | British | 580060001 | ||||||
| HAMPEL, Paul Leonard | Diretor | 13 Pottery Lane CM1 4HH Chelmsford Essex | British | 57201570001 | ||||||
| HAMPEL, Paul Leonard | Diretor | 13 Pottery Lane CM1 4HH Chelmsford Essex | British | 57201570001 | ||||||
| JAKES, Clifford Duncan | Diretor | Littlehay Burley BH24 4AG Ringwood Hampshire | British | 8426370001 | ||||||
| MAIR, Denise Margaret | Diretor | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | 99076200001 | |||||
| MATTHEW, Michael | Diretor | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | 40092920001 | ||||||
| MAY, Stephen John | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | United Kingdom | British | 173367920001 | |||||
| MEREDITH, Charles Lloyd | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 189455000001 | |||||
| MORGAN, Alan Ronald George | Diretor | 11 Wavell Court Elgin Road CR0 6XB Croydon | British | 46480460001 | ||||||
| PYPER, Richard John | Diretor | 24 Bourne Close EN10 7NE Broxbourne Hertfordshire | British | 74495760001 | ||||||
| RICH, Marcus Alvin | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 185688190001 | |||||
| ROSEN, Howard Norman | Diretor | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | 111282190001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lh Media Limited | 06/04/2016 | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
LINK HOUSE MAGAZINES LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 13/08/1999 Entregue em 02/09/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Breve descrição Link house 9 dingwall avenue croydon offices and 36 parking spaces; 23-25A george street croydon surrey studio offices workshops storage and 8 parking spaces; 583 fulham road london SW6 office and 2 parking spaces .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of amendment amending a deed of accession between the chargor, ipc magazines (UK) limited and the security agent supplemental to the debenture dated 19TH january 1998 as supplemented and amended on 22ND april 1998 and 12TH october 1998 | Criado em 22/12/1998 Entregue em 06/01/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future monies and liabilities of the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of accession supplemental to the debenture and the debenture | Criado em 12/10/1998 Entregue em 15/10/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 31/03/1995 Entregue em 08/04/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0