LH MEDIA LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | LH MEDIA LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03028809 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LH MEDIA LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica LH MEDIA LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de LH MEDIA LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| LH MAGAZINES (HOLDINGS) LIMITED | 24/04/1995 | 24/04/1995 |
| MELODYIMAGE LIMITED | 03/03/1995 | 03/03/1995 |
Quais são as últimas contas de LH MEDIA LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para LH MEDIA LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior prorrogado de 31/12/2018 para 30/06/2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Alteração dos detalhes de uma pessoa com controlo significativo | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Room 3-C29 Blue Fin Building 110 Southwark Street London SE1 0SU England para 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR em 20/08/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Término da nomeação de Marcus Alvin Rich como diretor em 13/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Stephen John May como diretor em 13/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Lauren Ezrol Klein como secretário em 31/01/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2018 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Joseph Henry Ceryanec como diretor em 15/02/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr John Stanley Zieser como diretor em 15/02/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Susana D'emic como diretor em 31/01/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/03/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Susana D'emic como diretor em 07/11/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jeffrey John Bairstow como diretor em 07/11/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Charles Lloyd Meredith como diretor em 31/05/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/03/2016 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Lauren Ezrol Klein em 28/01/2016 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de LH MEDIA LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERYANEC, Joseph Henry | Diretor | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United States | American | 243478830001 | |||||
| ZIESER, John Stanley | Diretor | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor United Kingdom | United States | American | 217687580001 | |||||
| BAKER, Edward James Macdonald | Secretário | 28 Aboyne Road SW17 0AE London | British | 40719330001 | ||||||
| DAVIES, John Graeme | Secretário | The Coach House Ghyll Head Waterhead LA22 0HD Ambleside Cumbria | British | 72253030001 | ||||||
| GORE, John Francis | Secretário | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Secretário | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Secretário | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| PYPER, Richard John | Secretário | 24 Bourne Close EN10 7NE Broxbourne Hertfordshire | British | 74495760001 | ||||||
| REDPATH, John | Secretário | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Secretário | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALEY, William Robert | Diretor | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Diretor | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Diretor | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Diretor | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Diretor | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| COSGROVE, Peter John | Diretor | 21 Kelsey Way BR3 3LP Beckenham Kent | United Kingdom | British | 580050001 | |||||
| D'EMIC, Susana Alves | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | United States | American | 265525580001 | |||||
| EVANS, Richard John | Diretor | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Diretor | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| LINDEN, Brian Andrew | Diretor | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | 36233000002 | |||||
| MAIR, Denise Margaret | Diretor | Whitehouse Farm Cottages School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent | United Kingdom | British | 99076200001 | |||||
| MATTHEW, Michael | Diretor | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | 40092920001 | ||||||
| MAY, Stephen John | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | United Kingdom | British | 173367920001 | |||||
| MCALPINE, Stuart Anderson | Diretor | 14 Grange Road Barnes SW13 9RE London | British | 97932330001 | ||||||
| MEREDITH, Charles Lloyd | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 189455000001 | |||||
| MORRISSEY, Patrick John | Diretor | 45 Woodlands Avenue KT3 3UH New Malden Surrey | United Kingdom | British | 46510670001 | |||||
| PYPER, Richard John | Diretor | 24 Bourne Close EN10 7NE Broxbourne Hertfordshire | British | 74495760001 | ||||||
| RICH, Marcus Alvin | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 185688190001 | |||||
| ROSEN, Howard Norman | Diretor | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | 111282190001 | |||||
| SHELDON, Jeremy Nigel | Diretor | Pasturewood House Abinger Lane, Abinger Common RH5 6JH Dorking Surrey | British | 80327250001 | ||||||
| WEBSTER, Evelyn Ann | Diretor | 15 Lansdowne Road SW20 8AN London | England | British | 68847920003 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Diretor nomeado | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de LH MEDIA LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipc Magazines (Uk) Limited | 04/06/2016 | 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29, Blue Fin Building England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
LH MEDIA LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 13/08/1999 Entregue em 02/09/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of amendment amending a deed of accession between the chargor, ipc magazines (UK) limited and the security agent supplemental to the debenture dated 19TH january 1998 as supplemented and amended on 22ND april 1998 and 12TH october 1998 | Criado em 22/12/1998 Entregue em 06/01/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future monies and liabilities of the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under under each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the dsenior facility documents (each as defined) | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of accession supplemental to the debenture and the debenture | Criado em 12/10/1998 Entregue em 15/10/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 31/03/1995 Entregue em 08/04/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0