MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED

MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 02428813
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CALDER ASHBY PROPERTY SYSTEMS LIMITED02/01/199002/01/1990
    GATEFIR LIMITED04/10/198904/10/1989

    Quais são as últimas contas de MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/04/2018

    Quais são as últimas submissões para MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW para 15 Canada Square London E14 5GL em 03/05/2019

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 03/04/2019

    LRESSP

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Contas de micro-entidade preparadas até 30/04/2018

    2 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 04/10/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Exercício contabilístico atual encurtado de 30/04/2019 para 31/03/2019

    1 páginasAA01

    Término da nomeação de Ian Michael Noble como diretor em 06/08/2018

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephen James Callaghan em 06/08/2018

    2 páginasCH01

    Contas de micro-entidade preparadas até 30/04/2017

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 04/10/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2016

    4 páginasAA

    Nomeação de Ian Michael Noble como diretor em 06/12/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew Coll como diretor em 06/12/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen James Callaghan como diretor em 10/10/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David John Meaden como diretor em 10/10/2016

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 04/10/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2015

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 04/10/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/11/2015

    Estado do capital em 02/11/2015

    • Capital: GBP 40,000
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2014

    4 páginasAA

    Nomeação de David John Meaden como diretor em 22/12/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de John Robert Stier como diretor em 22/12/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Pinsent Masons Secretarial Limited como secretário em 22/12/2014

    2 páginasAP04

    Quem são os diretores de MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Secretário
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Secretário
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    EMERTON, Leslie David
    Pentarrow
    39 Elphinstone Road Highcliffe
    BH23 5LL Christchurch
    Dorset
    Secretário
    Pentarrow
    39 Elphinstone Road Highcliffe
    BH23 5LL Christchurch
    Dorset
    British49739670002
    HARDING, Gary John
    3 Denham Close
    HP2 7JW Hemel Hempstead
    Herts
    Secretário
    3 Denham Close
    HP2 7JW Hemel Hempstead
    Herts
    British33944660001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Secretário
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Secretário
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    MURRAY, Margaret
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    Secretário
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    British27816020002
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Secretário
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretário
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    ASHBY, Peter Anthony
    46 Manford Way
    IG7 4JG Chigwell
    Essex
    Diretor
    46 Manford Way
    IG7 4JG Chigwell
    Essex
    British4998540001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Diretor
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish70199330002
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    Diretor
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish93657140001
    BRITTAIN, David Leonard
    The Gables Avey Lane
    EN9 3QH Waltham Abbey
    Essex
    Diretor
    The Gables Avey Lane
    EN9 3QH Waltham Abbey
    Essex
    British70451880001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    DAMIRAL, Alan
    18 Paddock Close
    St Marys Platt
    TN15 8NN Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    18 Paddock Close
    St Marys Platt
    TN15 8NN Sevenoaks
    Kent
    British21498890001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Diretor
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    British104554430001
    MASSIE, Michael Leslie
    Homeleigh 218 Main Road
    Hoo
    ME3 9HG Rochester
    Kent
    Diretor
    Homeleigh 218 Main Road
    Hoo
    ME3 9HG Rochester
    Kent
    United KingdomBritish21498880001
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    MOORE, Graham Anthony
    81 Aldwick Felds
    Aldwick
    PO21 3TH Bognor Regis
    W Sussex
    Diretor
    81 Aldwick Felds
    Aldwick
    PO21 3TH Bognor Regis
    W Sussex
    British53937410001
    MURRAY, Lawrence John
    Michaelmas Lodge
    Sandy Down Boldre
    SO41 8PN Lymington
    Hampshire
    Diretor
    Michaelmas Lodge
    Sandy Down Boldre
    SO41 8PN Lymington
    Hampshire
    British27816030003
    MURRAY, Margaret
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    Diretor
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    British27816020002
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    O'KEEFE, Gerard Patrick
    10 Cornes Close
    SO22 5DS Winchester
    Hampshire
    Diretor
    10 Cornes Close
    SO22 5DS Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish96633370001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Diretor
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish93738770001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Diretor
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Diretor
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritish76976490001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Diretor
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002

    Quem são as pessoas com controle significativo de MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro03495019
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Criado em 16/02/2007
    Entregue em 01/03/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/03/2007Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Criado em 15/02/2007
    Entregue em 01/03/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/03/2007Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 28/11/2006
    Entregue em 30/11/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 30/11/2006Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Criado em 28/02/2006
    Entregue em 02/03/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 02/03/2006Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Criado em 09/12/2002
    Entregue em 13/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 13/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 01/10/1999
    Entregue em 20/10/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and any documents supplemental thereto
    Breve descrição
    The deposit account which the deposit of £15,000 has been paid.
    Pessoas com direito
    • Vemore Limited
    Transações
    • 20/10/1999Registro de uma garantia (395)
    • 09/05/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 05/01/1999
    Entregue em 08/01/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and any documents supplemental thereto
    Breve descrição
    The deposit account which the deposit of £6,171 has been paid.
    Pessoas com direito
    • Vemore Limited
    Transações
    • 08/01/1999Registro de uma garantia (395)
    • 10/04/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 26/08/1992
    Entregue em 04/09/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/09/1992Registro de uma garantia (395)
    • 07/03/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    03/04/2019Início da liquidação
    01/02/2020Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0