RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED

RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaRUBY DCO TWENTY TWO LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa SC053733
    JurisdiçãoEscócia
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Scotland
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    KYLE AND CARRICK HOLDINGS LIMITED01/08/197301/08/1973

    Quais são as últimas contas de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2022

    Quais são as últimas submissões para RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Alteração dos detalhes de Ruby Dco Twenty One Limited como pessoa com controlo significativo em 18/09/2023

    2 páginasPSC05

    Alteração dos detalhes de Ayrshire Pharmaceuticals Limited como pessoa com controlo significativo em 04/09/2023

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland para Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP em 18/09/2023

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Graham Wiseman como diretor em 31/08/2023

    1 páginasTM01

    Nomeação de Thorsten Sprank como diretor em 31/08/2023

    2 páginasAP01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Sole director appointment 31/08/2023
    RES13

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed kyle and carrick holdings LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name04/09/2023

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Estado do capital em 15/08/2023

    • Capital: GBP 0.01
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 27/01/2023 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2022

    3 páginasAA

    Término da nomeação de Wendy Margaret Hall como diretor em 09/09/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Nichola Louise Legg como secretário em 09/09/2022

    1 páginasTM02

    Alteração do nome ou designação da classe de ações

    2 páginasSH08

    Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações

    2 páginasSH10

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Memorando e estatutos

    33 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Removal of restriction on authorised share capital/ ratification of directors actions 07/09/2022
    RES13
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    capital

    Resolução de alteração dos direitos ou da designação das ações

    RES12
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Nomeação de Graham Wiseman como diretor em 07/09/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Christian Keen como diretor em 18/05/2022

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SPRANK, Thorsten
    Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Diretor
    Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretário
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Secretário
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secretário
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    GILMOUR, David Strachan
    5 Laigh Mount
    KA7 4QS Ayr
    South Ayrshire
    Scotland
    Secretário
    5 Laigh Mount
    KA7 4QS Ayr
    South Ayrshire
    Scotland
    British52130850001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secretário
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretário
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    163214890001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secretário
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    RAINEY, Gary
    95 Greenacres
    KA22 7PR Ardrossan
    Ayrshire
    Secretário
    95 Greenacres
    KA22 7PR Ardrossan
    Ayrshire
    British3535890001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Secretário
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secretário
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    BEER, Thorsten
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman172030260001
    COCKBURN, Henry James Kemp
    16 Dalzell Avenue
    ML1 2BX Motherwell
    Lanarkshire
    Diretor
    16 Dalzell Avenue
    ML1 2BX Motherwell
    Lanarkshire
    British504660001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    GILBERT, George Andrew
    Tredawn White Plains
    KA7 4 Ayr
    Diretor
    Tredawn White Plains
    KA7 4 Ayr
    British469190001
    HALL, Wendy Margaret
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Diretor
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    JOHNSTONE, Ian
    47 Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    Lanarkshire
    Diretor
    47 Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish58656120002
    KEEN, Christian
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    Diretor
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Diretor
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman220582440001
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Diretor
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    British2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Diretor
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    MCCONNELL, Walter Scott
    Braehead Of Priestgill
    ML10 6PS Strathaven
    Diretor
    Braehead Of Priestgill
    ML10 6PS Strathaven
    British469160001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Diretor
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Diretor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    PRINGLE, John Stock
    Upper Carbarns Farm
    Netherton
    ML2 0RW Wishaw
    Diretor
    Upper Carbarns Farm
    Netherton
    ML2 0RW Wishaw
    British355710003
    RILLIE, George Davidson
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Diretor
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    British88210002
    RILLIE, George Davidson
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Diretor
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    British88210002
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Diretor
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Diretor
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritish1415570001
    TAYLOR, Andrew James
    7 Milton Gardens
    Calderbraes
    G71 6EB Uddingston
    Diretor
    7 Milton Gardens
    Calderbraes
    G71 6EB Uddingston
    British29348070001
    TURNER, Richard Gill
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    Diretor
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    British51796560002

    Quem são as pessoas com controle significativo de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    06/04/2016
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridade legalCompanies Act 1985
    Local de registroCompanies House
    Número de registroSc040149
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, influência ou controle significativo sobre as atividades de uma firma que, segundo a lei que a regula, não é uma pessoa jurídica; e os membros dessa firma (na sua qualidade como tal) detêm, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Standard security
    Criado em 04/05/1990
    Entregue em 14/05/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Long lease of shop 178 main street auchinleck, ayrshire.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/05/1990Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 04/05/1990
    Entregue em 14/05/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    27 townhead street cumnock, ayr.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/05/1990Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 04/05/1990
    Entregue em 14/05/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Shop at 67-73 high street, maybole ayrshire.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/05/1990Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 13/04/1990
    Entregue em 02/05/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    123/129 high st lanark 116/118 north vennel lanark.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 02/05/1990Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 05/02/1990
    Entregue em 14/02/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    64 mid street bathgate.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/02/1990Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 12/10/1989
    Entregue em 20/10/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Unit 4 & 4A glasgow road burnbank glasgow lan 57118.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 20/10/1989Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 10/03/1987
    Entregue em 19/03/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    268 glasgow rd blantyre.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 19/03/1987Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 17/11/1986
    Entregue em 04/12/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    (1) 270/272 glasgow road, blantyre (2) one up left 4 joanna terrace, blantyre one up right 4 joanna terrace blantyre regd title no lan 20237.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 04/12/1986Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 02/05/1984
    Entregue em 10/05/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Shop premises at 48 hanover street stranraer wigtownshire.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/05/1984Registro de uma garantia
    Standard security
    Criado em 02/05/1984
    Entregue em 10/05/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Shop premises at 19 the foregate kilmarnock.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/05/1984Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 02/05/1984
    Entregue em 10/05/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Shop premises at 33 burnbank road, hamilton.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/05/1984Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 02/05/1984
    Entregue em 10/05/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Shop premises at 57 portland place hamilton.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/05/1984Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Standard security
    Criado em 02/05/1984
    Entregue em 10/05/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Tennents interest in lease of shop premises known as 15 burnbank centre glasgow rd burnbank.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 10/05/1984Registro de uma garantia
    • 30/07/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)
    Bond & floating charge
    Criado em 22/03/1984
    Entregue em 28/03/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums due or to become due
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 28/03/1984Registro de uma garantia
    • 20/05/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (419a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0