MITRE SECRETARIES LIMITED - Página 22
Executivo Corporativo
Nome | MITRE SECRETARIES LIMITED |
---|---|
É Executivo Corporativo | Sim |
Nomeações | |
Ativo | 3 |
Inativo | 136 |
Renunciado | 767 |
Total | 906 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Função | Endereço |
---|---|---|---|---|---|
HARWICH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED | 02/07/1997 | 05/08/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
PART MANAGEMENT LIMITED | 02/07/1997 | 17/07/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BIODIVERSITY TRADING COMPANY LIMITED | 02/07/1997 | 20/02/1998 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
NATIONAL GRID INTERCONNECTORS LIMITED | 12/06/1997 | 18/08/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
WINDMILL HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED | 05/06/1997 | 17/11/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CRITERION ASSET MANAGEMENT LIMITED | 05/06/1997 | 08/05/1998 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
WIZARD INNS LIMITED | 03/04/1997 | 02/02/1998 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
RUGBY VALLEY PARK MANAGEMENT LIMITED | 25/03/1997 | 04/08/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
PJ PRINTING LIMITED | 25/03/1997 | 20/05/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
RIBOTARGETS HOLDINGS LIMITED | 25/03/1997 | 23/04/2003 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
PRAIA GRANDE LIMITED | 17/03/1997 | 06/06/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ANGEL TRAINS CONSULTING LIMITED | 17/03/1997 | 09/05/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ANGEL TRAIN CONTRACTS LIMITED | 17/03/1997 | 27/03/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ADAS RESEARCH FOUNDATION LIMITED | 21/02/1997 | 20/02/1998 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ADAS PENSION TRUSTEES LIMITED | 21/02/1997 | 20/02/1998 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ROSANTO PHARMACEUTICALS LTD | 21/02/1997 | 01/04/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BOURN ESTATES LIMITED | 17/02/1997 | 12/03/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SICAME UK LIMITED | 17/02/1997 | 07/03/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CABLE REALISATIONS LIMITED | 27/12/1996 | 07/03/1997 | Liquidação | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
AD3 REALISATIONS LIMITED | 12/12/1996 | 20/02/1998 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SHUKCO 327 LTD | 25/11/1996 | 04/03/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
IPT EMPLOYEE BENEFIT TRUSTEES LIMITED | 25/11/1996 | 31/01/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
HERBERT DOVE TRUSTEES LIMITED | 25/11/1996 | 26/05/1998 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
UNITED WASTE PROPERTY LIMITED | 25/11/1996 | 04/03/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CMS CAMERON MCKENNA PENSION TRUSTEES LIMITED | 30/10/1996 | 21/11/2022 | Dissolvida | Secretário nomeado | Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place, 78 England |
CAMERON MCKENNA LIMITED | 30/10/1996 | 07/11/2022 | Ativa | Secretário nomeado | Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place, 78 England |
JACQUES VERT BRANDS LIMITED | 30/10/1996 | 08/01/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
THAMES VALLEY PARK MANAGEMENT LIMITED | 30/10/1996 | 28/06/1999 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
R S M B AUDIENCE RESEARCH LTD | 21/10/1996 | 06/12/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BIFFA (UK) HOLDINGS LIMITED | 12/09/1996 | 24/12/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
MEDLINE INDUSTRIES LIMITED | 15/08/1996 | 30/09/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
UNIVET LIMITED | 15/08/1996 | 23/10/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
DOCKSIDE DEVELOPMENTS LIMITED | 13/08/1996 | 08/10/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CYCLACEL LIMITED | 13/08/1996 | 10/09/1996 | Liquidação | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 05/08/1996 | 22/08/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0