MITRE SECRETARIES LIMITED - Página 24
Executivo Corporativo
Nome | MITRE SECRETARIES LIMITED |
---|---|
É Executivo Corporativo | Sim |
Nomeações | |
Ativo | 5 |
Inativo | 136 |
Renunciado | 765 |
Total | 906 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Função | Endereço |
---|---|---|---|---|---|
ANGEL TRAINS CONSULTING LIMITED | 17/03/1997 | 09/05/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ROSANTO PHARMACEUTICALS LTD | 21/02/1997 | 01/04/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ANGEL TRAIN CONTRACTS LIMITED | 17/03/1997 | 27/03/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SPENCER PRIVATE HOSPITALS LIMITED | 23/11/1995 | 13/03/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BOURN ESTATES LIMITED | 17/02/1997 | 12/03/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SICAME UK LIMITED | 17/02/1997 | 07/03/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CABLE REALISATIONS LIMITED | 27/12/1996 | 07/03/1997 | Liquidação | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SHUKCO 327 LTD | 25/11/1996 | 04/03/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
UNITED WASTE PROPERTY LIMITED | 25/11/1996 | 04/03/1997 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
IPT EMPLOYEE BENEFIT TRUSTEES LIMITED | 25/11/1996 | 31/01/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
JACQUES VERT BRANDS LIMITED | 30/10/1996 | 08/01/1997 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BIFFA (UK) HOLDINGS LIMITED | 12/09/1996 | 24/12/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
R S M B AUDIENCE RESEARCH LTD | 21/10/1996 | 06/12/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
UNIVET LIMITED | 15/08/1996 | 23/10/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
DOCKSIDE DEVELOPMENTS LIMITED | 13/08/1996 | 08/10/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
PADENOME LIMITED | 12/02/1996 | 25/09/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CYCLACEL LIMITED | 13/08/1996 | 10/09/1996 | Liquidação | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SERVISAIR (CONTRACT HANDLING) LIMITED | 05/08/1996 | 30/08/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
CAMBRIDGE ANTIBODY TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 05/08/1996 | 22/08/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
NICKELODEON INTERNATIONAL LIMITED | 30/07/1996 | 22/08/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
RADIUS PENSION TRUSTEES LIMITED | 17/06/1996 | 08/08/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ORBICHEM LIMITED | 05/08/1996 | 07/08/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
HEATHROW CARGO HANDLING LIMITED | 05/07/1995 | 12/07/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ST GEORGE REAL ESTATE LIMITED | 04/03/1996 | 18/06/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
OLDCO LIMITED | 04/03/1996 | 17/05/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
VOSPER-MANTECH LIMITED | 09/03/1995 | 11/04/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ABACUS POLAR LIMITED | 27/10/1995 | 03/04/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
LGC LIMITED | 18/11/1994 | 28/03/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
TRL LIMITED | 29/12/1995 | 25/03/1996 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
WALKERS SNACK SERVICES LIMITED | 31/08/1995 | 15/03/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ELGA GROUP SERVICES LIMITED | 12/02/1996 | 13/03/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
J T DESIGN BUILD LIMITED | 09/03/1995 | 09/03/1996 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BABCOCK WEST SUSSEX CAREERS LIMITED | 23/11/1995 | 18/12/1995 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
IBC FOURTEEN LIMITED | 27/10/1995 | 15/12/1995 | Dissolvida | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BABCOCK SOUTHERN CAREERS LIMITED | 09/01/1995 | 13/12/1995 | Ativa | Secretário nomeado | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0