• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Kevin Charles MCCABE - Página 9

    Pessoa Física

    Título
    Primeiro NomeKevin
    Segundo NomeCharles
    Último NomeMCCABE
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo14
    Inativo6
    Renunciado279
    Total299

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    EUROPA HOMES LIMITED12/05/199510/01/2000DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    RELAND (WEEDON) LIMITED19/11/199701/09/1999DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    GLADEDALE (SOUTH EAST) LIMITED16/09/199601/09/1999AtivaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED23/01/199220/08/1999DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    RIVERSIDE COURT (SALTAIRE) MANAGEMENT COMPANY LIMITED16/05/199404/08/1999AtivaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    CURTBAY LIMITED03/09/199609/07/1999DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED11/11/199717/11/1998DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    CUTLERS HOLDINGS LIMITED14/01/199708/09/1998LiquidaçãoDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    CHESSER PROPERTIES LIMITED20/01/199425/03/1998AtivaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    TULLOCH RESORTS LIMITED02/04/199128/11/1997DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    TRINITY HOMES (SCOTLAND) LIMITED25/09/199609/12/1996DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    FRASERS HOMES (UK) LIMITED23/05/199416/06/1995AtivaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    FRASERS (BROWN STREET) LIMITED04/03/199416/06/1995AtivaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    FRASERS PROJECTS LIMITED26/02/199316/06/1995AtivaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    FRASERS FB (HOUSE) LIMITED26/02/199316/06/1995Acordo voluntárioDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    FRASERS FB (UK) G LIMITED21/12/199216/06/1995AtivaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    TULLOCH HOMES (WEST) LIMITED06/03/199225/11/1994DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED23/09/1993DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British
    CANTIME (SCARBOROUGH) LIMITED08/12/1992DissolvidaDiretor
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0