BELLA REALISATIONS 2 LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииBELLA REALISATIONS 2 LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 00964194
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель BELLA REALISATIONS 2 LIMITED?

    • Рестораны с лицензией (56101) / Гостиницы и рестораны

    Где находится BELLA REALISATIONS 2 LIMITED?

    Юридический адрес
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия BELLA REALISATIONS 2 LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    BELLA ITALIA RESTAURANTS LIMITED16 мая 2006 г.16 мая 2006 г.
    BRIGHTREASONS RESTAURANTS LIMITED20 апр. 1994 г.20 апр. 1994 г.
    PIZZALAND INTERNATIONAL LIMITED 16 мая 1991 г.16 мая 1991 г.
    PIZZALAND LIMITED21 февр. 1991 г.21 февр. 1991 г.
    ASSOCIATED RESTAURANTS LIMITED17 окт. 1969 г.17 окт. 1969 г.

    Каковы последние отчеты BELLA REALISATIONS 2 LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на26 мая 2019 г.

    Какие последние документы подавались BELLA REALISATIONS 2 LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Отказ от бесхозяйного имущества

    страницыBONA

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Уведомление о переходе от администрации к роспуску

    37 страницыAM23

    Отчет о ходе администрации

    35 страницыAM10

    Назначение администратора

    страницыAM01

    Отчет о ходе администрации

    36 страницыAM10

    Уведомление об отставке администратора

    4 страницыAM15

    Уведомление о продлении срока администрации

    4 страницыAM19

    Назначение администратора

    страницыAM01

    Отчет о ходе администрации

    44 страницыAM10

    Отчет о ходе администрации

    46 страницыAM10

    Уведомление о продлении срока администрации

    5 страницыAM19

    Отчет о ходе администрации

    66 страницыAM10

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 009641940034

    11 страницыMR05

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 009641940032

    11 страницыMR05

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 009641940035

    11 страницыMR05

    Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью обременения 009641940033

    11 страницыMR05

    Юридический адрес изменен с 8th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WB на Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU 11 нояб. 2020 г.

    2 страницыAD01

    Прекращение полномочий Adrian Rowland Walker в качестве директора 08 окт. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Прекращение полномочий James Forrester Spragg в качестве директора 08 окт. 2020 г.

    1 страницыTM01

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed bella italia restaurants LIMITED\certificate issued on 15/10/20
    3 страницыCERTNM
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Уведомление об изменении наименования"

    2 страницыCONNOT

    Заявление о состоянии дел с приложенной формой AM02SOA

    9 страницыAM02

    Уведомление о предполагаемом одобрении предложений

    5 страницыAM06

    Заявление о предложениях администратора

    99 страницыAM03

    Кто является должностными лицами BELLA REALISATIONS 2 LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    BUXTON SMITH, Maria Rita
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    Секретарь
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    British39442340002
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Секретарь
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    237559750001
    FENTON, Nicola Jane
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    Секретарь
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    BritishCommercial Lawyer31440290005
    FRANKLIN, Robert Norman Carew
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    Секретарь
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    British37258120002
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Секретарь
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    BritishFinance Director64318140001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Секретарь
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    BritishDirector49107830002
    SIMS, Robin Edward
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    Секретарь
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    British52343580001
    ASPEL, Edward
    2 Christ Church Cottages
    Christ Church Road
    GU25 4PT Virginia Water
    Surrey
    Директор
    2 Christ Church Cottages
    Christ Church Road
    GU25 4PT Virginia Water
    Surrey
    BritishDirector62933370001
    BAKER, Ian Stewart
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    Директор
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    BritishCompany Director67628330002
    BAKER, Ian Stewart
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    Директор
    26 Oakdene
    SL5 0BU Sunningdale
    Berkshire
    BritishCompany Director67628330002
    BARBOUR, Niel Paterson
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    Директор
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    BritishGroup Operation Director71423490001
    CLEWLEY, Robert Richard
    Sunfield House
    Tonbridge Road
    TN15 9AR Ightham
    Kent
    Директор
    Sunfield House
    Tonbridge Road
    TN15 9AR Ightham
    Kent
    United KingdomBritishExecutive85729830001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Директор
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritishAccountant187907210001
    DAVIS, Samantha Clare
    14 Links Drive
    WD6 3PS Elstree
    Hertfordshire
    Директор
    14 Links Drive
    WD6 3PS Elstree
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector125626320001
    DERKACH, John
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Директор
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    United KingdomBritishCeo113885080002
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Директор
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    DUDLEY, Stuart
    1 The Old Vicarage
    OX17 1SA Wardington
    Oxfordshire
    Директор
    1 The Old Vicarage
    OX17 1SA Wardington
    Oxfordshire
    BritishPurchasing Director66322690001
    EVANS, John Stephen David
    Courtyard Cottage
    4 The Toft
    WA16 9EH Toft Road Knutsford
    Cheshire
    Директор
    Courtyard Cottage
    4 The Toft
    WA16 9EH Toft Road Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishCaterer92401670001
    FERNANDEZ, Sara Kathryn
    31 Theobalds Way
    Frimley
    GU16 5RF Camberley
    Surrey
    Директор
    31 Theobalds Way
    Frimley
    GU16 5RF Camberley
    Surrey
    BritishSales Dir43206820001
    GREEN, Christopher David
    Springfield Barn
    The Avenue, Barnsdale
    LE15 8AH Oakham
    Rutland
    Директор
    Springfield Barn
    The Avenue, Barnsdale
    LE15 8AH Oakham
    Rutland
    EnglandEnglishMarketing Director100789790001
    GUTHRIE, Garth Michael
    Hyde Heath Farm
    Hyde Heath
    HP6 5RW Amersham
    Buckinghamshire
    Директор
    Hyde Heath Farm
    Hyde Heath
    HP6 5RW Amersham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director51714120001
    HANNA, Chaker
    61 Longlands Road
    DA15 7LQ Sidcup
    Kent
    Директор
    61 Longlands Road
    DA15 7LQ Sidcup
    Kent
    BritishOperations Director43872760001
    HENFREY, Anthony William, Dr
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    Директор
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    EnglandBritishCompany Director42207200001
    JOHNSON, Michael Andrew
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    Директор
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director98243170001
    JOHNSON, Rowland Christopher
    3 Duck End Lane
    MK45 2DL Maulden
    Bedfordshire
    Директор
    3 Duck End Lane
    MK45 2DL Maulden
    Bedfordshire
    BritishDirector71910140001
    LESTER, Jeremy William
    24 Hillview
    2-4 Primrose Hill Road
    NW3 3AX London
    Директор
    24 Hillview
    2-4 Primrose Hill Road
    NW3 3AX London
    BritishAccountant50628960002
    LONG, Jeremy Paul Warwick
    31 Alwyne Road
    Islington
    N1 2HW London
    Директор
    31 Alwyne Road
    Islington
    N1 2HW London
    BritishCompany Director7764450001
    LUDBROOK, Michael Sydney
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    Директор
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    BritishCompany Director60035400001
    LUDBROOK, Michael Sydney
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    Директор
    9 Pavely Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    BritishCompany Director60035400001
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Директор
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritishCompany Director64318140002
    MANSIGANI, Mohan
    36 Copthall Drive
    Mill Hill
    NW7 2NB London
    Директор
    36 Copthall Drive
    Mill Hill
    NW7 2NB London
    United KingdomBritishFinance Director64318140001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Директор
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    BritishDirector49107830002
    PARSONS, James
    East Heath Road
    NW3 1AL London
    17
    United Kingdom
    Директор
    East Heath Road
    NW3 1AL London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector98887110002
    PENNY, Michael William Harrison
    6 Guildcroft
    GU1 2JU Guildford
    Surrey
    Директор
    6 Guildcroft
    GU1 2JU Guildford
    Surrey
    BritishFinance Director22553680001
    RICHARDS, Stephen
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Директор
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector187618040002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над BELLA REALISATIONS 2 LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер02521829
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у BELLA REALISATIONS 2 LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A registered charge
    Создан 14 янв. 2020 г.
    Поставлен 16 янв. 2020 г.
    Не погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Транзакции
    • 16 янв. 2020 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 нояб. 2020 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 15 авг. 2018 г.
    Поставлен 31 авг. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The charged property (as defined under the supplemental debenture). For more details please refer to the supplemental debenture, the security agreement (as defined in the supplemental debenture) and the chargor's deed of accession thereto.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Транзакции
    • 31 авг. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 нояб. 2020 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 15 авг. 2018 г.
    Поставлен 21 авг. 2018 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    None at the date of the charge.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Транзакции
    • 21 авг. 2018 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 нояб. 2020 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 05 февр. 2016 г.
    Поставлен 09 февр. 2016 г.
    Не погашен
    Краткое описание
    The security document enclosed with this form MR01 includes a fixed charge or a fixed security over land and intellectual property, including the basement and ground floor premises at 25 argyll street and 1 little argyll street, london. For more details of the land and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Транзакции
    • 09 февр. 2016 г.Регистрация залога (MR01)
    • 14 нояб. 2020 г.Часть имущества или предприятия освобождена и больше не является частью залога (MR05)
    A registered charge
    Создан 20 июл. 2015 г.
    Поставлен 07 авг. 2015 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    "Bella pasta pasta cafe (stylised)" trademark, registration number 394040880, 39404088. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Транзакции
    • 07 авг. 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    • 19 февр. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 12 мая 2015 г.
    Поставлен 15 мая 2015 г.
    Полностью погашен
    Краткое описание
    German trademark bella pasta pasta cafe (stylised) 394040880 and 39404088 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S.Bank Trustees Limited (In Its Capacity as Seurity Agent for the Beneficiaries)
    Транзакции
    • 15 мая 2015 г.Регистрация залога (MR01)
    • 19 февр. 2016 г.Удовлетворение залога (MR04)
    A registered charge
    Создан 30 сент. 2014 г.
    Поставлен 03 окт. 2014 г.
    Полностью погашен
    Плавающая залог охватывает все: Да
    Содержит негативное обязательство: Да
    Содержит плавающий залог: Да
    Содержит фиксированный залог: Да
    Уполномоченные лица
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Транзакции
    • 03 окт. 2014 г.Регистрация залога (MR01)
    • 25 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed and floating security document
    Создан 25 июл. 2007 г.
    Поставлен 31 июл. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All its right, title and interest in and to the assigned contracts all insurances and a fixed charge on all present and future real property. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Транзакции
    • 31 июл. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Fixed and floating security document
    Создан 22 янв. 2007 г.
    Поставлен 26 янв. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All right title and interest in and to the assigned contracts, all insurances and a fixed charge present and future real property and other assets. Floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Транзакции
    • 26 янв. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 июл. 2015 г.Удовлетворение залога (MR04)
    Debenture
    Создан 25 мая 2006 г.
    Поставлен 09 июн. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    All property,first fixed charge all other property,all licences,all computers,vehicles,office equipment and other equipment,the benefit of all contracts,licences and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC the "Security Agent"
    Транзакции
    • 09 июн. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental deed
    Создан 25 нояб. 2005 г.
    Поставлен 30 нояб. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    L/H property k/a unit G40B, lowry centre, salford. L/h property k/a units 3 and 5 longmarket, canterbury. L/h property k/a unit 1 derry's cross, plymouth. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC 'Security Agent'
    Транзакции
    • 30 нояб. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Deed of accession and amendment
    Создан 28 апр. 2005 г.
    Поставлен 10 мая 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    A grant of security over all security interests and disposistions and are created with a full title guarantee and are continuing security for payment of all of the secured obligations. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC ( the Security Agent)
    Транзакции
    • 10 мая 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 17 янв. 2005 г.
    Поставлен 29 янв. 2005 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    Properties k/a argyll street, london-25 argyll street; birmingham-103-104 the charters new street t/no WM412377; bournemouth-84 old christchurch road. For details of further properties charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Транзакции
    • 29 янв. 2005 г.Регистрация обременения (395)
    • 25 янв. 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Создан 31 мая 2002 г.
    Поставлен 11 июн. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Краткое описание
    20A winchester street basingstoke; unit 1 bishops wharf 39 and 49 parkgate road; 296/298 high street berkhamsted t/nos: HP536633 TGL104043 HD351012. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Barclays Bank PLC
    Транзакции
    • 11 июн. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 февр. 2005 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Guarantee and debenture
    Создан 12 окт. 1995 г.
    Поставлен 19 окт. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the debenture and loan agreement of even date
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Mercury Asset Management PLC
    Транзакции
    • 19 окт. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 11 сент. 1995 г.
    Поставлен 19 сент. 1995 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself, the arranger and each bank (as defined in the facility agreement dated 20 february 1991) and the governor and company of the bank of scotland as overdraft bank, under the terms of the financing documents (as defined in the facility agreement) or any of them
    Краткое описание
    All and whole that area of land at aviemore in the united parish of duthil and rothiemurchus and county of inverness and highland region extending to one hundred and seventy five decimal parts of an hectare or thereby (0.175HA) ...... see the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Транзакции
    • 19 сент. 1995 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Debenture
    Создан 28 февр. 1994 г.
    Поставлен 21 мар. 1994 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the finance documents (as defined) and/or this deed
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co. Limited as Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Транзакции
    • 21 мар. 1994 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 23 февр. 1993 г.
    Поставлен 12 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined)
    Краткое описание
    Ground floor premises at 5 frederick street edinburgh midlothian.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co Limited as Agent and Trustee as Defined
    Транзакции
    • 12 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 23 февр. 1993 г.
    Поставлен 12 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company and each obligor to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for itself and each bank
    Краткое описание
    The basement restaurant 15A castle street and ground mezzanine and first floors of 15 castle street edinburgh.see frm 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for Itself and Each Bank
    Транзакции
    • 12 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 23 февр. 1993 г.
    Поставлен 12 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company to samuel montagu & co.limited as agent and trustee for itself and each bank as defined
    Краткое описание
    100-112 renfield street and 47-59 sauchiehall street glasgow.see form 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co.Limitedas Agent and Trustee for Itself and Each Bank
    Транзакции
    • 12 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 23 февр. 1993 г.
    Поставлен 12 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company and each obligor to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for itself and each of the banks as defined
    Краткое описание
    Ground floor and basement of 13-15 saint vincent place glasgow.see form 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co.Limited Definedas Agent and Trustee for Itself and Each Bank As
    Транзакции
    • 12 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 23 февр. 1993 г.
    Поставлен 12 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company and each obligor to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for itself and each bank as defined
    Краткое описание
    Ground floor and first basement 23 north bridge edinburgh.see form 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co.Limited Definedas Agent and Trustee for Itself and Each Bank As
    Транзакции
    • 12 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Standard security
    Создан 23 февр. 1993 г.
    Поставлен 12 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from the company and each obligor to samuel montagu & co.limited as agent and trustee for itself and each bank as defined
    Краткое описание
    53/55 port street stirling see form 395 for full details.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co. Limited as Agent and Trustee for Itself and the Banks as Defined
    Транзакции
    • 12 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Supplemental debenture
    Создан 18 февр. 1993 г.
    Поставлен 10 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from each obligor to the chargee under each of the finance documents
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co as Agent and Trustee for Itself, Itself as Arranger and Each Bank and Theoverdraft Bank
    Транзакции
    • 10 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mezzanine debenture
    Создан 18 февр. 1993 г.
    Поставлен 10 мар. 1993 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due from each obligor to the chargee under each of the financing documents
    Краткое описание
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Уполномоченные лица
    • Samuel Montagu & Co Limited as Agent and Trustee for Itself and Each Lender
    Транзакции
    • 10 мар. 1993 г.Регистрация обременения (395)
    • 06 дек. 1996 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у BELLA REALISATIONS 2 LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    20 июн. 2014 г.Дата собрания для утверждения CVA
    22 июл. 2016 г.Дата завершения или прекращения CVA
    Добровольное соглашение с кредиторами (CVA)
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Практик
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Практик
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Практик
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    ДатаТип
    02 июл. 2020 г.Начало управления
    29 июн. 2023 г.Окончание управления
    На стадии управления
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Catherine Williamson
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Практик
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Clare Kennedy
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Практик
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Практик
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Daniel Imison
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Практик
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0