MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииMICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 02428813
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    • Прочие виды деятельности в области информационных технологий (62090) / Информация и связь

    Где находится MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Юридический адрес
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    CALDER ASHBY PROPERTY SYSTEMS LIMITED02 янв. 1990 г.02 янв. 1990 г.
    GATEFIR LIMITED04 окт. 1989 г.04 окт. 1989 г.

    Каковы последние отчеты MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 апр. 2018 г.

    Какие последние документы подавались MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    6 страницыLIQ13

    Юридический адрес изменен с Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW на 15 Canada Square London E14 5GL 03 мая 2019 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 03 апр. 2019 г.

    LRESSP

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Бухгалтерская отчетность для микропредприятия

    2 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 04 окт. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Ian Michael Noble в качестве директора 06 авг. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Изменение данных директора для Mr Stephen James Callaghan 06 авг. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Бухгалтерская отчетность для микропредприятия

    3 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 04 окт. 2017 г. без изменений

    3 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Назначение Ian Michael Noble на должность директора 06 дек. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Andrew Coll в качестве директора 06 дек. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Stephen James Callaghan на должность директора 10 окт. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David John Meaden в качестве директора 10 окт. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 04 окт. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital02 нояб. 2015 г.

    Отчет о капитале на 02 нояб. 2015 г.

    • Капитал: GBP 40,000
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Назначение David John Meaden на должность директора 22 дек. 2014 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий John Robert Stier в качестве директора 22 дек. 2014 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Pinsent Masons Secretarial Limited на должность секретаря 22 дек. 2014 г.

    2 страницыAP04

    Кто является должностными лицами MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Секретарь
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Секретарь
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    EMERTON, Leslie David
    Pentarrow
    39 Elphinstone Road Highcliffe
    BH23 5LL Christchurch
    Dorset
    Секретарь
    Pentarrow
    39 Elphinstone Road Highcliffe
    BH23 5LL Christchurch
    Dorset
    British49739670002
    HARDING, Gary John
    3 Denham Close
    HP2 7JW Hemel Hempstead
    Herts
    Секретарь
    3 Denham Close
    HP2 7JW Hemel Hempstead
    Herts
    British33944660001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Секретарь
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Секретарь
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    MURRAY, Margaret
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    Секретарь
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    British27816020002
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Секретарь
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Секретарь
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    ASHBY, Peter Anthony
    46 Manford Way
    IG7 4JG Chigwell
    Essex
    Директор
    46 Manford Way
    IG7 4JG Chigwell
    Essex
    British4998540001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Директор
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish70199330002
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    Директор
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish93657140001
    BRITTAIN, David Leonard
    The Gables Avey Lane
    EN9 3QH Waltham Abbey
    Essex
    Директор
    The Gables Avey Lane
    EN9 3QH Waltham Abbey
    Essex
    British70451880001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    DAMIRAL, Alan
    18 Paddock Close
    St Marys Platt
    TN15 8NN Sevenoaks
    Kent
    Директор
    18 Paddock Close
    St Marys Platt
    TN15 8NN Sevenoaks
    Kent
    British21498890001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Директор
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    British104554430001
    MASSIE, Michael Leslie
    Homeleigh 218 Main Road
    Hoo
    ME3 9HG Rochester
    Kent
    Директор
    Homeleigh 218 Main Road
    Hoo
    ME3 9HG Rochester
    Kent
    United KingdomBritish21498880001
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    MOORE, Graham Anthony
    81 Aldwick Felds
    Aldwick
    PO21 3TH Bognor Regis
    W Sussex
    Директор
    81 Aldwick Felds
    Aldwick
    PO21 3TH Bognor Regis
    W Sussex
    British53937410001
    MURRAY, Lawrence John
    Michaelmas Lodge
    Sandy Down Boldre
    SO41 8PN Lymington
    Hampshire
    Директор
    Michaelmas Lodge
    Sandy Down Boldre
    SO41 8PN Lymington
    Hampshire
    British27816030003
    MURRAY, Margaret
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    Директор
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    British27816020002
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    O'KEEFE, Gerard Patrick
    10 Cornes Close
    SO22 5DS Winchester
    Hampshire
    Директор
    10 Cornes Close
    SO22 5DS Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish96633370001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Директор
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish93738770001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Директор
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritish76976490001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Директор
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаLimited By Shares
    Страна регистрацииEngland And Wales
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер03495019
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Создан 16 февр. 2007 г.
    Поставлен 01 мар. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 01 мар. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Создан 15 февр. 2007 г.
    Поставлен 01 мар. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 01 мар. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 28 нояб. 2006 г.
    Поставлен 30 нояб. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 30 нояб. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Создан 28 февр. 2006 г.
    Поставлен 02 мар. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 02 мар. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Создан 09 дек. 2002 г.
    Поставлен 13 дек. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 13 дек. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 01 окт. 1999 г.
    Поставлен 20 окт. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and any documents supplemental thereto
    Краткое описание
    The deposit account which the deposit of £15,000 has been paid.
    Уполномоченные лица
    • Vemore Limited
    Транзакции
    • 20 окт. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 09 мая 2007 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Rent deposit deed
    Создан 05 янв. 1999 г.
    Поставлен 08 янв. 1999 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and any documents supplemental thereto
    Краткое описание
    The deposit account which the deposit of £6,171 has been paid.
    Уполномоченные лица
    • Vemore Limited
    Транзакции
    • 08 янв. 1999 г.Регистрация обременения (395)
    • 10 апр. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Mortgage debenture
    Создан 26 авг. 1992 г.
    Поставлен 04 сент. 1992 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Уполномоченные лица
    • National Westminster Bank PLC
    Транзакции
    • 04 сент. 1992 г.Регистрация обременения (395)
    • 07 мар. 2002 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    03 апр. 2019 г.Начало ликвидации
    01 февр. 2020 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Практик
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Практик
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0