NPS (UK8) LIMITED

  • Обзор
  • Резюме
  • Цель
  • Адрес
  • Предыдущие названия
  • Бухгалтерские отчеты
  • Подачи документов
  • Руководители
  • Лица, оказывающие значительное влияние
  • Залоги
  • Несостоятельность
  • Источник данных
  • Обзор

    Название компанииNPS (UK8) LIMITED
    Статус компанииЛиквидирована
    Организационно-правовая формаОбщество с ограниченной ответственностью
    Номер компании 04045673
    ЮрисдикцияАнглия/Уэльс
    Дата создания
    Дата прекращения деятельности

    Резюме

    Имеет суперзащищенные PSCsНет
    Имеет залогиДа
    Имеет историю несостоятельностиДа
    Юридический адрес оспариваетсяНет

    Какова цель NPS (UK8) LIMITED?

    • Прочие виды деятельности в области информационных технологий (62090) / Информация и связь

    Где находится NPS (UK8) LIMITED?

    Юридический адрес
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Юридический адрес недоступен для доставкиНет

    Какие были предыдущие названия NPS (UK8) LIMITED?

    Предыдущие названия компании
    Название компанииСПо
    NORTHGATE.NET LIMITED09 янв. 2009 г.09 янв. 2009 г.
    ANITE.NET LIMITED11 авг. 2000 г.11 авг. 2000 г.
    HALLCO 484 LIMITED02 авг. 2000 г.02 авг. 2000 г.

    Каковы последние отчеты NPS (UK8) LIMITED?

    Последние отчеты
    Последние отчеты составлены по состоянию на30 апр. 2018 г.

    Какие последние документы подавались NPS (UK8) LIMITED?

    Подачи документов
    ДатаОписаниеДокументТип

    Окончательная публикация в бюллетене, ликвидированная в результате ликвидации

    1 страницыGAZ2

    Возвращение окончательного собрания в добровольной ликвидации членов

    6 страницыLIQ13

    Юридический адрес изменен с Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW на 15 Canada Square London E14 5GL 03 мая 2019 г.

    2 страницыAD01

    Назначение ликвидатора

    3 страницы600

    Решения

    Resolutions
    1 страницыRESOLUTIONS
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    liquidation

    Добровольное специальное решение о ликвидации с даты начала дела 03 апр. 2019 г.

    LRESSP

    Заявление о платежеспособности

    5 страницыLIQ01

    Бухгалтерская отчетность для микропредприятия

    2 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 02 авг. 2018 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Текущий отчетный период сокращен

    1 страницыAA01

    Прекращение полномочий Ian Michael Noble в качестве директора 06 авг. 2018 г.

    1 страницыTM01

    Изменение данных директора для Mr Stephen James Callaghan 06 авг. 2018 г.

    2 страницыCH01

    Укороченная неаудированная финансовая отчетность на 30 апр. 2017 г.

    7 страницыAA

    Уведомление о подтверждении, составленное 02 авг. 2017 г. с изменениями

    4 страницыCS01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Назначение Ian Michael Noble на должность директора 06 дек. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий Andrew Coll в качестве директора 06 дек. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Назначение Mr Stephen James Callaghan на должность директора 10 окт. 2016 г.

    2 страницыAP01

    Прекращение полномочий David John Meaden в качестве директора 10 окт. 2016 г.

    1 страницыTM01

    Уведомление о подтверждении, составленное 03 авг. 2016 г. с изменениями

    5 страницыCS01

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital13 мая 2016 г.

    Отчет о капитале на 13 мая 2016 г.

    • Капитал: GBP 197.49
    SH01

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Годовой отчет с полным списком акционеров

    5 страницыAR01
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    capital28 авг. 2015 г.

    Отчет о капитале на 28 авг. 2015 г.

    • Капитал: GBP 197.49
    SH01

    Свидетельство об изменении наименования компании

    Company name changed northgate.net LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 страницыCERTNM
    Связанные подачи
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name16 июн. 2015 г.

    Изменение наименования" по решению

    NM01
    Решения
    КатегорияДатаОписаниеТип
    change-of-name

    Решение об изменении наименования

    RES15

    Бухгалтерский баланс для спящей компании

    4 страницыAA

    Назначение David John Meaden на должность директора 22 дек. 2014 г.

    2 страницыAP01

    Кто является должностными лицами NPS (UK8) LIMITED?

    Руководители
    ИмяНазначенУшел в отставкуРольАдресИдентификация компанииСтрана проживанияГражданствоДата рожденияПрофессияНомер
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Секретарь компании
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Тип идентификацииЕЭЗ
    Регистрационный номер2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    Секретарь
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    British97291590001
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Секретарь
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Секретарь
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Секретарь
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Секретарь
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Секретарь
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Секретарь
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Секретарь
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Секретарь
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Секретарь
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    British14373460003
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Номинированный секретарь
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Директор
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish70199330002
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    Директор
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish97291590001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Директор
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    British104554430001
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Директор
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    MCCANN, James
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    Директор
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    British69923680001
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    SLOGGETT, David Raymond, Dr
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    Директор
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    British34112730001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Директор
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Директор
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Директор
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritish76976490001
    THORPE, David Allan
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    Директор
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    United KingdomBritish77702540001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Директор
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Директор
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    British14373460003
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Номинированный директор
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Кто является лицами, осуществляющими значительный контроль над NPS (UK8) LIMITED?

    Лица, оказывающие значительное влияние
    ИмяУведомленАдресПрекращено
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    United Kingdom
    06 апр. 2016 г.
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    United Kingdom
    Нет
    Организационно-правовая формаPrivate Limited Company
    Страна регистрацииUnited Kingdom (England And Wales)
    Юридическое основаниеUnited Kingdom (England And Wales)
    Место регистрацииCompanies House
    Регистрационный номер03495019
    Характер контроля
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно владеет более чем 75% голосующих акций компании.
    • Лицо прямо или косвенно имеет право назначать или освобождать от должности большинство членов совета директоров компании.

    Есть ли у NPS (UK8) LIMITED какие-либо обременения?

    Залоги
    КлассификацияДатыСтатусПодробности
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Создан 16 февр. 2007 г.
    Поставлен 01 мар. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 01 мар. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Создан 15 февр. 2007 г.
    Поставлен 01 мар. 2007 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 01 мар. 2007 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Создан 28 нояб. 2006 г.
    Поставлен 30 нояб. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 30 нояб. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Создан 28 февр. 2006 г.
    Поставлен 02 мар. 2006 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 02 мар. 2006 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Создан 09 дек. 2002 г.
    Поставлен 13 дек. 2002 г.
    Полностью погашен
    Обеспеченная сумма
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Краткое описание
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Уполномоченные лица
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Транзакции
    • 13 дек. 2002 г.Регистрация обременения (395)
    • 31 окт. 2008 г.Заявление о полном или частичном погашении залога (403a)

    Есть ли у NPS (UK8) LIMITED какие-либо дела о несостоятельности?

    Дело №ДатыТипПрактикиДругое
    1
    ДатаТип
    03 апр. 2019 г.Начало ликвидации
    01 февр. 2020 г.Дата ликвидации
    Добровольная ликвидация по решению участников
    ИмяРольАдресНазначенПрекращено
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Практик
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Практик
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Источник данных

    • Companies House Великобритании
      Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность.
    • Лицензия: CC0