ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03792893 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| A S G MIDLANDS LIMITED | 21. Juni 1999 | 21. Juni 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Change of details for Castlegate 796 Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Change of details for Castlegate 796 Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Beendigung der Bestellung von Rjp Secretaries Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Cossey Cosec Services Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022 | 1 Seiten | CH02 | ||
Change of details for Ansa Utilities Limited as a person with significant control on 09. Juni 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 7 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 7 Seiten | AA | ||
Change of details for Ansa Utilities Limited as a person with significant control on 09. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England zum Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL am 12. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Rjp Secretaries Limited am 09. Aug. 2019 | 1 Seiten | CH04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSSEY COSEC SERVICES LIMITED | Sekretär | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 302964180001 | ||||||||||
| PACE, Stuart | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | England | British | 207506130003 | |||||||||
| GOLD ROUND LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 | ||||||||||
| BOYES, Stephen | Sekretär | Grassdale Cottage Valley Road, Houghton Bottoms PR5 0SD Preston Lancashire | British | 78387220001 | ||||||||||
| DAVIS, Peter Nicholas | Sekretär | 35 Chatsworth Road Eccles M30 9DZ Manchester Lancashire | British | 29902470001 | ||||||||||
| DICKINSON, Louise | Sekretär | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | British | 139480580001 | ||||||||||
| GRAEME, Dorothy May | Bevollmächtigter Sekretär | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||||||
| MCINNES, Timothy Ian | Sekretär | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | British | 108973030002 | ||||||||||
| PRILL, Robert David | Sekretär | Moorfield, Roe Green Worsley M28 2FL Manchester 8 United Kingdom | British | 131613520001 | ||||||||||
| WATKINS, Steven James | Sekretär | Roscownans Old Kea TR3 6AX Truro Cornwall | British | 127928260001 | ||||||||||
| RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
| BARRETT, John | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | United Kingdom | British | 118475070001 | |||||||||
| BROOK, Philip John | Geschäftsführer | 8 Hillside Drive BH23 2RU Christchurch Dorset | British | 64789650001 | ||||||||||
| DAVIS, Peter Nicholas | Geschäftsführer | 35 Chatsworth Road Eccles M30 9DZ Manchester Lancashire | England | British | 29902470001 | |||||||||
| DICKINSON, Louise | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 139480580001 | |||||||||
| GRAEME, Lesley Joyce | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||||||
| HORTON, Alan Albert | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | 182208240001 | |||||||||
| LEE, Peter Francis | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 207608120001 | |||||||||
| LEES, Stuart | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 70032700001 | |||||||||
| LLOYD JONES, Andrew Mark | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 180809810001 | |||||||||
| MAHONEY, Kevin David | Geschäftsführer | 6 Ferrymans Quay William Morris Way SW6 2UT London | United Kingdom | British | 63238350002 | |||||||||
| MAUDE, Simon David | Geschäftsführer | The Main Hall Rufford Park Lane Rufford L40 1XE Ormskirk 1 Lancashire | United Kingdom | British | 89719660003 | |||||||||
| MCINNES, Timothy Ian | Geschäftsführer | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 108973030002 | |||||||||
| POLLARD, Niall Mackinlay | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Fulwood Park Lancashire | England | British | 176786520001 | |||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | United Kingdom | British | 207506140001 | |||||||||
| TURNER, Paul Leslie | Geschäftsführer | Netherlaw Greendale Lane SK10 4AY Mottram St Andrew Cheshire | British | 72964390004 | ||||||||||
| VINCENT, Michael | Geschäftsführer | 23 Saint Aubyns's Avenue SW19 7BL London | England | British | 99258270001 | |||||||||
| WATKINS, Steven James | Geschäftsführer | Park Crescent TR11 2DL Falmouth 1 Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | 127928260002 | |||||||||
| WATKINS, Steven James | Geschäftsführer | Roscownans Old Kea TR3 6AX Truro Cornwall | British | 127928260001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Round Limited | 18. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street W1S 4AW Mayfair 4th Floor London United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Gold Round Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Castlegate 796 Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 16. Juni 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. Juni 2009 Geliefert am 02. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juni 2009 Geliefert am 30. Juni 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession deed | Erstellt am 30. Juni 2005 Geliefert am 06. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The payment of the secured liabilities,any f/h or l/h property,its interest in present and future licences,fixed charge all othe present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juni 2004 Geliefert am 02. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Sept. 2002 Geliefert am 21. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Sept. 2001 Geliefert am 27. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0