ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03792893
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    A S G MIDLANDS LIMITED21. Juni 199921. Juni 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Change of details for Castlegate 796 Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023

    2 SeitenPSC05

    Change of details for Castlegate 796 Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023

    2 SeitenPSC05

    Beendigung der Bestellung von Rjp Secretaries Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Cossey Cosec Services Limited als Sekretär am 25. Jan. 2023

    2 SeitenAP04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2022 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022

    2 SeitenPSC05

    Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 25. Juli 2022

    1 SeitenCH02

    Change of details for Ansa Utilities Limited as a person with significant control on 09. Juni 2022

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 18. Apr. 2016

    2 SeitenPSC05

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019

    7 SeitenAA

    Change of details for Ansa Utilities Limited as a person with significant control on 09. Aug. 2019

    2 SeitenPSC05

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England zum Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL am 12. Aug. 2019

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Sekretärs für Rjp Secretaries Limited am 09. Aug. 2019

    1 SeitenCH04

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COSSEY COSEC SERVICES LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer14344691
    302964180001
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish207506130003
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer05687325
    149588400001
    BOYES, Stephen
    Grassdale Cottage
    Valley Road, Houghton Bottoms
    PR5 0SD Preston
    Lancashire
    Sekretär
    Grassdale Cottage
    Valley Road, Houghton Bottoms
    PR5 0SD Preston
    Lancashire
    British78387220001
    DAVIS, Peter Nicholas
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    British29902470001
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Sekretär
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    British139480580001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    British108973030002
    PRILL, Robert David
    Moorfield, Roe Green
    Worsley
    M28 2FL Manchester
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Moorfield, Roe Green
    Worsley
    M28 2FL Manchester
    8
    United Kingdom
    British131613520001
    WATKINS, Steven James
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    Sekretär
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    British127928260001
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer02989995
    61999120002
    BARRETT, John
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    United KingdomBritish118475070001
    BROOK, Philip John
    8 Hillside Drive
    BH23 2RU Christchurch
    Dorset
    Geschäftsführer
    8 Hillside Drive
    BH23 2RU Christchurch
    Dorset
    British64789650001
    DAVIS, Peter Nicholas
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish29902470001
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish139480580001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish182208240001
    LEE, Peter Francis
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish207608120001
    LEES, Stuart
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish70032700001
    LLOYD JONES, Andrew Mark
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish180809810001
    MAHONEY, Kevin David
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    Geschäftsführer
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    United KingdomBritish63238350002
    MAUDE, Simon David
    The Main Hall
    Rufford Park Lane Rufford
    L40 1XE Ormskirk
    1
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Main Hall
    Rufford Park Lane Rufford
    L40 1XE Ormskirk
    1
    Lancashire
    United KingdomBritish89719660003
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish108973030002
    POLLARD, Niall Mackinlay
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish176786520001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritish207506140001
    TURNER, Paul Leslie
    Netherlaw
    Greendale Lane
    SK10 4AY Mottram St Andrew
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Netherlaw
    Greendale Lane
    SK10 4AY Mottram St Andrew
    Cheshire
    British72964390004
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Geschäftsführer
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WATKINS, Steven James
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish127928260002
    WATKINS, Steven James
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    British127928260001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    24 Old Bond Street
    W1S 4AW Mayfair
    4th Floor
    London
    United Kingdom
    18. Apr. 2016
    24 Old Bond Street
    W1S 4AW Mayfair
    4th Floor
    London
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05687325
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer05687325
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03792812
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 01. Sept. 2016
    Geliefert am 13. Sept. 2016
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Blackstar 2016 Limited
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Juni 2016
    Geliefert am 16. Juni 2016
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Secure Trust Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Jan. 2011
    Geliefert am 08. Feb. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 26. Juni 2009
    Geliefert am 02. Juli 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Investor)
    Transaktionen
    • 02. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juni 2009
    Geliefert am 30. Juni 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 30. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Accession deed
    Erstellt am 30. Juni 2005
    Geliefert am 06. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The payment of the secured liabilities,any f/h or l/h property,its interest in present and future licences,fixed charge all othe present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC ("the Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 2004
    Geliefert am 02. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barrington House Nominees Limited (Customer B) (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Sept. 2002
    Geliefert am 21. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Sept. 2001
    Geliefert am 27. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0