James John JORDAN - Page 13
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | James |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | JORDAN |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 3 |
Inactif | 48 |
Démissionné | 395 |
Total | 446 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANHOPE CAMBRIDGE LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
A.M. MARKETING SOUTHERN LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
A.M. MARKETING SOUTHERN LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
CHARCO 351 LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
CHARCO 351 LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
EGERTON CONTRACTS LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
COMPINE DEVELOPMENTS LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
COMPINE DEVELOPMENTS LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
MCA THAMES VALLEY LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
MCA THAMES VALLEY LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
MCA NORTH EAST LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Liquidation | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
MCA NORTH EAST LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Liquidation | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
CALDERS GREEN (MANAGEMENT) COMPANY LIMITED | 12 nov. 2007 | 13 nov. 2007 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
UK HOME FINANCE LIMITED | 09 mai 2003 | 31 janv. 2007 | Dissoute | Solicitor/Co Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
NORTH CENTRAL MANAGEMENT LIMITED | 01 nov. 2004 | 22 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
NORTH CENTRAL MANAGEMENT HOLDING COMPANY LIMITED | 30 juin 2004 | 22 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
GW CITY VENTURES LIMITED | 22 déc. 2004 | 28 juil. 2006 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | |
GN TOWER LIMITED | 22 déc. 2004 | 28 juil. 2006 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | |
GWNW CITY DEVELOPMENTS LIMITED | 21 juil. 2005 | 17 juil. 2006 | Active | Solicitor Company Secretary | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | |
FALCON WHARF LIMITED | 21 juil. 2005 | 11 juil. 2006 | Active | Solicitor Company Secretary | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | |
GEORGE WIMPEY PENSION TRUSTEES LIMITED | 05 janv. 2005 | 05 janv. 2005 | Dissoute | Solicitor Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
MOLINS U.K. PENSION FUND TRUSTEE LIMITED | 01 sept. 2000 | 01 févr. 2002 | Active | Solicitor | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
MPAC CORPORATE SERVICES LIMITED | 08 août 2000 | 01 févr. 2002 | Active | Solicitor | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
MPAC GROUP PLC | 07 août 2000 | 01 févr. 2002 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
ECC OVERSEAS INVESTMENTS | 17 juin 1999 | Dissoute | Deputy Solicitor | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British | |
IMERYS TRUSTEES LIMITED | 18 juin 1993 | 31 juil. 1995 | Active | Deputy Solicitor | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0