James John JORDAN - Page 10
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | James |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | JORDAN |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 3 |
Inactif | 48 |
Démissionné | 395 |
Total | 446 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCA WEST MIDLANDS LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
MCLEAN HOMES SOUTHERN LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
SHOWPINE LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
GEORGE WIMPEY SOUTH YORKSHIRE LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
WHATCO ENGLAND LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
MCA NORTH EAST LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Liquidation | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
CANDLEMAKERS (TW) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
COMPINE DEVELOPMENTS (MUNDFORD) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
MCA (KENDAL) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
GEORGE WIMPEY SOUTH WEST LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
LAING HOMES LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
MCA EAST LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
COMPINE DEVELOPMENTS (MUNDFORD) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
FAIRHOLD ATLAS LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
TAYLOR WIMPEY DEVELOPMENTS LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
L.& A.FREEMAN LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
MCA LAND LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
GEORGE WIMPEY WEST MIDLANDS LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
GEORGE WIMPEY SOUTHERN COUNTIES LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
PAYCAUSE LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
WHATCO ENGLAND LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
GEORGE WIMPEY CITY 2 LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
MCA LAND LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
HASSALL HOMES (CHESHIRE) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
HASSALL HOMES (CHESHIRE) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
PAYCAUSE LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
ASHFIELD INVESTMENTS LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
GEORGE WIMPEY NORTH EAST LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
IVA ESTATES LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
HASSALL HOMES (MERCIA) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Active | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
ST. ANNE'S VILLAGE LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
CORNEY REACH LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British |
IVA (MIDLANDS) LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | ||
EGERTON CONSTRUCTION CO.LIMITED | 31 déc. 2007 | 06 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0