• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • James John JORDAN - Page 4

    Personne physique

    TitreMr
    PrénomJames
    Deuxième prénomJohn
    Nom de familleJORDAN
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif3
    Inactif48
    Démissionné395
    Total446

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    WIMPEY LAING LIMITED04 févr. 200231 déc. 2019LiquidationCompany SecretaryAdministrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    WIMPEY LAING OVERSEAS LIMITED04 févr. 200231 déc. 2019LiquidationCompany SecretaryAdministrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    GEORGE WIMPEY LIMITED04 févr. 200231 déc. 2019ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British
    WIMPEY DORMANT INVESTMENTS LIMITED04 févr. 200231 déc. 2019ActiveCompany SecretaryAdministrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    THAMESWEY HOMES LIMITED04 févr. 200231 déc. 2019ActiveCompany SecretaryAdministrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    WIMPEY CONSTRUCTION OVERSEAS LIMITED04 févr. 200231 déc. 2019ActiveCompany SecretaryAdministrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    WIMPEY CORPORATE SERVICES LIMITED31 janv. 200231 déc. 2019ActiveCompany SecretaryAdministrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    TAYLOR WIMPEY PLC03 juil. 200704 nov. 2019ActiveSecrétaire
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British
    THE TENNIS FOUNDATION (LEGACY)25 mai 201701 mai 2019ActiveDirector/Company SecretaryAdministrateur
    100 Priory Lane
    Roehampton
    SW15 5JQ London
    EnglandBritish
    WILSON CONNOLLY LOGISTICS LIMITED16 oct. 200805 juil. 2018DissouteCompany SecretaryAdministrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    WILCON CONSTRUCTION LIMITED16 oct. 200805 juil. 2018DissouteCompany SecretaryAdministrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    THE SECRET GARDEN MANAGEMENT COMPANY LIMITED19 mars 200707 mai 2015ActiveSolicitorAdministrateur
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish
    TW CAVENDISH HOLDINGS LIMITED03 avr. 200719 juil. 2010DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    New Bond Street
    W1S 1SB London
    80
    United Kingdom
    British
    WIMPEY CARS MANAGEMENT LIMITED04 févr. 200207 déc. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY FINANCE PLC04 févr. 200207 déc. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    GEORGE WIMPEY (CW) LIMITED26 juin 200601 déc. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY OVERSEAS HOLDINGS LIMITED04 févr. 200201 déc. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY GROUP SERVICES LIMITED04 févr. 200201 déc. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    MCA PARTNERSHIP LIMITED04 févr. 200201 déc. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY CORPORATE SERVICES LIMITED31 janv. 200201 déc. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY GEOTECH LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY GULF HOLDINGS LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY DORMANT INVESTMENTS LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY LAING OVERSEAS LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009LiquidationSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY LAING LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009LiquidationSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WORANES INVESTMENTS LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY ENGINEERING LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY OFFSHORE ENGINEERS & CONSTRUCTORS LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY ME&C OVERSEAS LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    WIMPEY CONSTRUCTION OVERSEAS LIMITED20 déc. 200426 janv. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    THAMESWEY HOMES LIMITED01 févr. 200523 janv. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    BLATCHINGTON ELEVEN LIMITED20 déc. 200423 janv. 2009LiquidationSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    THOMAS LOWE AND SONS,LIMITED20 déc. 200423 janv. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    ETTINGSHALL DEVELOPMENTS LIMITED20 déc. 200423 janv. 2009DissouteSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British
    JIM 5 LIMITED20 déc. 200423 janv. 2009ActiveSolicitor/Company SecretarySecrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0