Lawrence John Vincent DONNELLY - Page 3
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Lawrence |
Deuxième prénom | John Vincent |
Nom de famille | DONNELLY |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 87 |
Total | 91 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC POWER DISTRIBUTION PLC | 19 mars 2001 | 22 janv. 2009 | Active | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION PLC | 19 mars 2001 | 22 janv. 2009 | Active | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC | 19 mars 2001 | 22 janv. 2009 | Active | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY POWER DISTRIBUTION LIMITED | 19 mars 2001 | 22 janv. 2009 | Active | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
INDIGO PIPELINES LIMITED | 04 févr. 1999 | 22 janv. 2009 | Active | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
S + S LIMITED | 19 mars 2001 | 22 janv. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
RENEWABLE TECHNOLOGY VENTURES LIMITED | 10 févr. 2006 | 27 sept. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
RENEWABLE DEVICES SWIFT TURBINES LIMITED | 23 mars 2006 | 08 déc. 2006 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | Scotland | British |
BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED | 01 oct. 2002 | 31 mars 2006 | Active | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
OVO (S) ELECTRICITY LIMITED | 26 mars 2001 | 18 avr. 2005 | Active | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
OVO (S) GAS LIMITED | 04 févr. 1999 | 18 avr. 2005 | Active | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
SWALEC GAS LIMITED | 07 août 2000 | 18 avr. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | ||
SSE ENERGY SUPPLY LIMITED | 07 août 2000 | 26 avr. 2004 | Active | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | ||
SOHONET LIMITED | 01 avr. 2003 | 22 août 2003 | Active | Solicitor | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | |
SSE SERVICES PLC | 04 févr. 1999 | 01 mai 1999 | Active | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | ||
SSE PLC | 03 juin 1993 | 01 mai 1999 | Active | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | ||
CORONA ENERGY RETAIL 2 LIMITED | 09 mars 1993 | 13 août 1993 | Active | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | ||
KEADBY GENERATION LIMITED | 02 oct. 1992 | 01 avr. 1993 | Active | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | ||
KEADBY DEVELOPMENTS LIMITED | 08 avr. 1992 | 01 avr. 1993 | Active | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | ||
KEADBY CONSTRUCTION LIMITED | 02 oct. 1992 | 01 avr. 1993 | Dissoute | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | ||
KEADBY POWER LIMITED | 01 avr. 1993 | Dissoute | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0