AZETS (CHBS) LIMITED - Page 12
Dirigeant de société
| Nom | AZETS (CHBS) LIMITED |
|---|---|
| Est un dirigeant de société | Oui |
| Nominations | |
| Actif | 4 |
| Inactif | 144 |
| Démissionné | 368 |
| Total | 516 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESS TRADE TOOLS LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| FLISS HOAD PUBLIC RELATIONS LIMITED | 06 avr. 2011 | 19 avr. 2023 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| AFFINITY MAGAZINES U.S.A. LIMITED | 06 avr. 2011 | 25 oct. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| VEHICLE TRANSPORTATION UK LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom | |
| WARWICK 3P LIMITED | 06 avr. 2011 | 24 oct. 2025 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| TREEFOLK LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX26 6QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| SILVERRAIL TECHNOLOGIES UK LIMITED | 06 avr. 2011 | 07 déc. 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| MK PROJECT OFFICE SOLUTIONS LTD | 06 avr. 2011 | 18 juil. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| ON TRACK PROPERTY LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| JUSTIN THYME LIMITED | 06 avr. 2011 | 30 sept. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| AZETS (BICESTER) LIMITED | 06 avr. 2011 | 28 avr. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| KNOWGAIN LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom | |
| MANZ PREMIUM LTD. | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| JONS CUTTING ROOM LIMITED | 06 avr. 2011 | 11 avr. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| RECYCLING PRODUCT LTD | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| MAZE INTERNATIONAL LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| STENMOORE CONSULTING LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom | |
| PHANTOM ENTERPRISE LIMITED | 06 avr. 2011 | 24 sept. 2025 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| PIERRE AUDOIN CONSULTANTS (PAC) LIMITED | 06 avr. 2011 | 07 déc. 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| LAVISIONUK LIMITED | 06 avr. 2011 | 30 nov. 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| PRODEMA UK & IRELAND LIMITED | 06 avr. 2011 | 20 mai 2016 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| BUSINESS REMIT LIMITED | 06 avr. 2011 | 05 juin 2017 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| COMBIBO'S LIMITED | 06 avr. 2011 | 24 mai 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| NIC COMPONENTS EUROPE LIMITED | 06 avr. 2011 | 28 nov. 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| WARWICK NORTON LTD | 06 avr. 2011 | 22 mars 2023 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| PROFESSIONAL EXCHANGE LTD | 06 avr. 2011 | 01 avr. 2013 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| VIATECH PUBLISHING SOLUTIONS LIMITED | 06 avr. 2011 | 29 nov. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| TWILIGHT FINANCES LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| MILLENNIUM HEALTH LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| LIFESIZE COMMUNICATIONS,LTD | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| LLT EXECUTIVE SEARCH LIMITED | 06 avr. 2011 | 03 avr. 2019 | Liquidation | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| KELMAC LIMITED | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| AZETS (CHG) LIMITED | 06 avr. 2011 | 28 avr. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| SIGMATIC LIMITED | 06 avr. 2011 | 03 déc. 2012 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| TETRAGONHR LIMITED | 06 avr. 2011 | 19 mai 2022 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0