AZETS (CHBS) LIMITED - Page 14
Dirigeant de société
| Nom | AZETS (CHBS) LIMITED |
|---|---|
| Est un dirigeant de société | Oui |
| Nominations | |
| Actif | 4 |
| Inactif | 144 |
| Démissionné | 368 |
| Total | 516 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNT TECHNOLOGIES SOFTWARE LIMITED | 05 avr. 2011 | 27 févr. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| CARTTRONICS EUROPE LIMITED | 05 avr. 2011 | 04 avr. 2017 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| AJEPCO LIMITED | 05 avr. 2011 | 05 avr. 2021 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| ST ENGINEERING ANTYCIP LTD | 05 avr. 2011 | 24 sept. 2025 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| CHANGING IN FLOW LTD | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| GRANTS INTERNATIONAL INFORMATION & SECURITY SERVICES LIMITED | 05 avr. 2011 | 01 sept. 2015 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| INTERPAK LTD | 05 avr. 2011 | 31 déc. 2024 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| INTERPAK LTD | 05 avr. 2011 | 15 avr. 2013 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| GRANTS INTERNATIONAL INFORMATION & SECURITY SERVICES LIMITED | 05 avr. 2011 | 24 sept. 2025 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| C & D PARTNERSHIP LIMITED | 05 avr. 2011 | 17 avr. 2012 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| HAWKINS PROTECTIVE COATINGS LIMITED | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom | |
| EVERON UK LIMITED | 05 avr. 2011 | 01 déc. 2015 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| E-TRADEWAY LIMITED | 05 avr. 2011 | 06 avr. 2011 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| E-TRADEWAY LIMITED | 05 avr. 2011 | 14 mars 2014 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| EVERON UK LIMITED | 05 avr. 2011 | 22 juil. 2020 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| BRUNEL OFFICE SUPPLIES LIMITED | 05 avr. 2011 | 07 déc. 2016 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| PENRITE CLASSIC OILS LIMITED | 05 avr. 2011 | 06 avr. 2011 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| DOMAINE CHATER LIMITED | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| APPLICATION SECURITY LTD | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| ALTERNATIVE ANGLES BUSINESS CONSULTANCY LIMITED | 05 avr. 2011 | 28 sept. 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| ADVANTAGE PROJECT MANAGEMENT LIMITED | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| HOSPITALITY MATTERS LIMITED | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom | |
| CHERWELL ROOFING LIMITED | 05 avr. 2011 | 10 juil. 2019 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| INFINITELY LIMITED | 05 avr. 2011 | 15 janv. 2014 | Active | Secrétaire | Great Horwood Road Winslow MK18 3LX Buckingham Washbrook Meadows England |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES U.K. LIMITED | 05 avr. 2011 | 10 juin 2016 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| B.P. BUILDING & CARPENTRY LIMITED | 05 avr. 2011 | 20 mai 2021 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| ASP ONLINE SOFTWARE LIMITED | 05 avr. 2011 | 24 oct. 2025 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| E-CREDIT PLUS LIMITED | 05 avr. 2011 | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| E-CREDIT PLUS LIMITED | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom | |
| EC FOOD SERVICES LIMITED | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| DEMANDWARE UK LIMITED | 05 avr. 2011 | 31 août 2017 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| CLASSIC RADIO SYSTEMS LIMITED | 05 avr. 2011 | 17 nov. 2017 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| BTSDF REGION 2 KATRINA CREASER LTD. | 05 avr. 2011 | 17 avr. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| ACCESSDATA CORPORATION LIMITED | 05 avr. 2011 | 12 oct. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| BIOEDGE PHARMA CONSULTANCY LIMITED | 05 avr. 2011 | 24 oct. 2025 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0