AZETS (CHBS) LIMITED - Page 15
Dirigeant de société
| Nom | AZETS (CHBS) LIMITED |
|---|---|
| Est un dirigeant de société | Oui |
| Nominations | |
| Actif | 4 |
| Inactif | 144 |
| Démissionné | 368 |
| Total | 516 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| GREEN HILLS SOFTWARE LTD. | 05 avr. 2011 | 17 mai 2016 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| GREEN HILLS SOFTWARE LTD. | 05 avr. 2011 | 07 déc. 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| FAT TREES GROUP LIMITED | 05 avr. 2011 | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| FAT TREES GROUP LIMITED | 05 avr. 2011 | 06 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| FAT TREES GROUP LIMITED | 05 avr. 2011 | 01 août 2015 | Dissoute | Secrétaire | Victoria Road OX26 6QB Bicester 2 Minton Place Oxfordshire |
| 586 SPORTS LTD | 05 avr. 2011 | 27 août 2013 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| HOMEGOODS LIMITED | 05 avr. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX26 6QB Bicester 2 Oxfordshire England | |
| THE BEECHES CAFE LIMITED | 05 avr. 2011 | 07 janv. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| FS ENGINEERING & OILFIELDS SUPPLY LIMITED | 05 avr. 2011 | 05 avr. 2011 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| FS ENGINEERING & OILFIELDS SUPPLY LIMITED | 05 avr. 2011 | 24 oct. 2025 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| INTERPOST LTD. | 05 avr. 2011 | 11 août 2015 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| INTERPOST LTD. | 05 avr. 2011 | 04 déc. 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| ELEGANT CUISINE LIMITED | 05 avr. 2011 | 20 mai 2019 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| ELEGANT CUISINE LIMITED | 05 avr. 2011 | 05 avr. 2011 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| TITAN SUPPLY CHAIN SERVICES LIMITED | 04 avr. 2011 | 29 nov. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| FINESSE FURNITURE LIMITED | 01 avr. 2011 | 14 août 2023 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD | 01 avr. 2011 | 16 juin 2015 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX26 6QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| ANCILE SOLUTIONS LTD. | 30 mars 2011 | 13 août 2012 | Active | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX266QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| JOINERY SPRAY FINISHING LIMITED | 14 mars 2011 | 05 juil. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX26 6QB Bicester 2 Oxfordshire United Kingdom |
| BRIGHT MARKET LLC DBA FASTSPRING LIMITED | 03 mars 2011 | 17 oct. 2025 | Active | Secrétaire | Regis House 45 King William Street EC4R 9AN London 2nd Floor United Kingdom |
| PROFILE RESOURCING LIMITED | 25 févr. 2011 | 31 mai 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| AS AEROSPACE LIMITED | 16 déc. 2010 | 29 nov. 2019 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| EPHESOFT UK LIMITED | 09 déc. 2010 | 24 juin 2020 | Dissoute | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
| DANIALAB LIMITED | 09 nov. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Minton Place Victoria Road OX26 6QB Bicester 2 Oxfordshire United Kingdom | |
| CLARK HOWES PARTNERSHIP LLP | 02 nov. 2010 | 01 juin 2011 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Minton Place Victoria Road OX26 6QB Bicester 2 Oxfordshire England |
| BALFA UK LIMITED | 30 sept. 2010 | 01 mai 2018 | Active | Secrétaire | 59 Lichfield Street WS4 2BX Walsall Churchill House West Midlands United Kingdom |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0