Dorothy May KANE - Seite 150
Natürliche Person
Titel | Mrs |
---|---|
Vorname | Dorothy |
Zweites Vornamen | May |
Nachname | KANE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 48 |
Zurückgetreten | 9443 |
Gesamt | 9491 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHINE FM | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Armagh | British | ||
G. WATTERS LTD | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive BT62 2BL Tandragee | British | ||
TAGGART HOMES (2) LIMITED | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
LODGE ROAD PROPERTY SEVEN LIMITED | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT622BL Co Armagh | British | ||
TAGGART HOMES (3) LIMITED | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tangragee BT62 2BL | British | ||
BANN ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Armagh | British | ||
BANN ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Armagh | Northern Ireland | British |
APREY DESIGN LTD | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive BT62 2BL Tandragee | British | ||
BENAGH CONSTRUCTION LTD | 21. Juni 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive BT62 2BL Tandragee | British | ||
HOOSTER LIMITED | 21. Apr. 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
ORTEGA PROPERTIES LIMITED | 23. Feb. 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
ORTEGA PROPERTIES LIMITED | 23. Feb. 2006 | 21. Juni 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
KILMEGAN LANE MANAGEMENT COMPANY LTD | 20. Juni 2006 | 20. Juni 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Road Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
WB CONTRACTS LIMITED | 07. Juni 2006 | 20. Juni 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
WB CONTRACTS LIMITED | 07. Juni 2006 | 20. Juni 2006 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
SMS ELECTRICAL LTD | 20. Juni 2006 | 20. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
VITA SPA UK LTD | 20. Juni 2006 | 20. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
MCCUSKER STABLING LIMITED | 20. Juni 2006 | 20. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT622BL Co Armagh | British | ||
MC3D LTD | 20. Juni 2006 | 20. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Road Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
VIPER PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 26. Mai 2006 | 20. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
VIPER PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 26. Mai 2006 | 20. Juni 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
DICKSON CONTRACTS LTD | 19. Juni 2006 | 19. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT622BL Co Armagh | British | ||
GLENCREW LIMITED | 31. Mai 2006 | 19. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
GLENCREW LIMITED | 31. Mai 2006 | 19. Juni 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
P H FLANIGAN LTD | 30. Mai 2006 | 16. Juni 2006 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
P H FLANIGAN LTD | 30. Mai 2006 | 16. Juni 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
GLASSEL PROPERTIES LIMITED | 27. Jan. 2006 | 16. Juni 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
GLASSEL PROPERTIES LIMITED | 27. Jan. 2006 | 16. Juni 2006 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
TRORY DEVELOPMENTS LIMITED | 25. Okt. 2005 | 16. Juni 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
TRORY DEVELOPMENTS LIMITED | 25. Okt. 2005 | 16. Juni 2006 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
MILLANOS LIQUID LOUNGE LTD | 16. Juni 2006 | 16. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT622BL Co Armagh | British | ||
GDC HELICOPTERS LIMITED | 16. Juni 2006 | 16. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT622BL Co Armagh | British | ||
RIVER BANN CRUISES LTD | 16. Juni 2006 | 16. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
OVERSEAS PROPERTY WORLDWIDE LIMITED | 16. Juni 2006 | 16. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
VICTORIAN GARDEN ARCHITECTURE LTD | 16. Juni 2006 | 16. Juni 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0