Dorothy May KANE - Seite 250
Natürliche Person
Titel | Mrs |
---|---|
Vorname | Dorothy |
Zweites Vornamen | May |
Nachname | KANE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 48 |
Zurückgetreten | 9443 |
Gesamt | 9491 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E & R LOGAN LIMITED | 06. März 2001 | 20. Feb. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
DEPUR SYSTEMS LTD | 05. Feb. 2002 | 15. Feb. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
LANDWOOD ENTERPRISES LIMITED | 05. Feb. 2002 | 14. Feb. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
COLIN MCCRORY LIMITED | 17. Dez. 2001 | 14. Feb. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
QUPURKT UNLIMITED | 13. Dez. 2001 | 14. Feb. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
KAINOS (PN) LIMITED | 13. Dez. 2001 | 12. Feb. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
GSR TECHNOLOGIES LTD | 05. Feb. 2002 | 08. Feb. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
OAMARU DEVELOPMENTS LIMITED | 04. Dez. 2001 | 06. Feb. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
EURO TRUCK MIXERS LTD | 30. Nov. 2001 | 05. Feb. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
SRS LTD | 30. Nov. 2001 | 04. Feb. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
JEC GROUP LTD | 21. Nov. 2001 | 04. Feb. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
MORTGAGE APPLICATIONS LIMITED | 13. Dez. 2001 | 31. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
BADGER CLOSE LIMITED | 13. Dez. 2001 | 31. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
MCSHANNON TRAILER SALES LIMITED | 30. Jan. 2002 | 30. Jan. 2002 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive BT62 2BL Tandragee County Armagh Northern Ireland | British | ||
SKERRY LIMITED | 17. Dez. 2001 | 30. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
MPB CONSTRUCTION LIMITED | 17. Dez. 2001 | 29. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
CONVENIENT STORES LIMITED | 13. Dez. 2001 | 29. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
MOUNTVIEW CONTRACTS LIMITED | 30. Nov. 2001 | 29. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
N.W. ESTATES LTD | 30. Nov. 2001 | 29. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
CARN PLASTICS LIMITED | 14. Mai 2001 | 28. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
LATT LIMITED | 21. Nov. 2001 | 24. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
SHENEARD MAINTENANCE COMPANY LTD | 30. Nov. 2001 | 24. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
ROYCE DEVELOPMENTS (BANGOR) LIMITED | 21. Nov. 2001 | 24. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
NORTHERN ENTERPRISE DEVELOPMENTS LIMITED | 17. Dez. 2001 | 18. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
MOBILE COHESION LIMITED | 21. Nov. 2001 | 18. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
STANG LIMITED | 17. Dez. 2001 | 14. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
ULSTER MAGAZINES LIMITED | 17. Dez. 2001 | 11. Jan. 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
NAVAN DEVELOPMENTS LIMITED | 30. Nov. 2001 | 09. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
MEADOWVALE DEVELOPMENTS LIMITED | 30. Nov. 2001 | 07. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
URBAN PROPERTY SOLUTIONS LTD | 07. Juli 2001 | 02. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
LANYON FINANCIAL PLANNING LIMITED | 02. Apr. 2001 | 01. Jan. 2002 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
CITY BUSINESS PARK MANAGEMENT CO LTD | 21. Nov. 2001 | 28. Dez. 2001 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
CABRAGH MUSHROOM COMPOSTS LIMITED | 18. Mai 2001 | 20. Dez. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
OPEN FAIRWAYS LIMITED | 30. Nov. 2001 | 20. Dez. 2001 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
DIVERSITY CHALLENGES PROJECT LTD | 30. Nov. 2001 | 20. Dez. 2001 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon Co Armagh | Northern Ireland | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0