• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Dorothy May KANE - Seite 173

    Natürliche Person

    TitelMrs
    VornameDorothy
    Zweites VornamenMay
    NachnameKANE
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv48
    Zurückgetreten9443
    Gesamt9491

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    TASCOMI LTD20. Jan. 200601. Feb. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    TASCOMI LTD20. Jan. 200601. Feb. 2006AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    Northern IrelandBritish
    CARRADALE PROPERTIES LIMITED21. Dez. 200501. Feb. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    CARRADALE PROPERTIES LIMITED21. Dez. 200501. Feb. 2006AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    Northern IrelandBritish
    STREETS AHEAD CLOTHING LTD31. Jan. 200631. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    TK CONSULTANCY (NI) LIMITED31. Jan. 200631. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    ULTIMATE RESULTS LIMITED31. Jan. 200631. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    PIPESKETCH LIMITED31. Jan. 200631. Jan. 2006LiquidationSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    REC CONSULTING LIMITED30. Jan. 200630. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    ARD CUAN CARE HOMES LTD20. Jan. 200630. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    ARD CUAN CARE HOMES LTD20. Jan. 200630. Jan. 2006AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    Northern IrelandBritish
    I-CAN CONSULTING LTD15. Dez. 200530. Jan. 2006AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Craigavon
    Northern IrelandBritish
    EAST ESSENCE LTD30. Jan. 200630. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    CRIEVE CONTRACTS LIMITED30. Jan. 200630. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    URETEK IRELAND LIMITED23. Jan. 200628. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    UNIQUE & ANTIQUE CONSTRUCTION CO. LTD03. Feb. 200627. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    RAVENHILL ESTATES LIMITED27. Jan. 200627. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    M.J. WOODWORKING MACHINERY LTD27. Jan. 200627. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    R I ANDREWS LTD27. Jan. 200627. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    JAMES MCKEE COFFEY & SONS FISHING LTD27. Jan. 200627. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    BMC CONTRACTS LTD27. Jan. 200627. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    REFRESHING SPRINGS LIMITED27. Jan. 200627. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    COUNTRY STOVES LTD27. Jan. 200627. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    FEHU DEVELOPMENTS LIMITED27. Jan. 200627. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    LITTLE OAK DEVELOPMENTS LIMITED26. Jan. 200626. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    A & C MAGINN LIMITED26. Jan. 200626. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    HOUSE OF FIREPLACES LIMITED19. Jan. 200626. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British
    HOUSE OF FIREPLACES LIMITED19. Jan. 200626. Jan. 2006AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    Northern IrelandBritish
    MVH HOMECARE HARDWARE LTD15. Dez. 200526. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Craigavon
    British
    MVH HOMECARE HARDWARE LTD15. Dez. 200526. Jan. 2006AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Craigavon
    Northern IrelandBritish
    CHARTERHOUSE ESTATE AGENTS LIMITED11. Jan. 200526. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Craigavon
    British
    CHARTERHOUSE ESTATE AGENTS LIMITED11. Jan. 200526. Jan. 2006AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL County Armagh
    Northern IrelandBritish
    CHARTERHOUSE FINANCIAL NEGOTIATIONS LIMITED11. Jan. 200526. Jan. 2006AktivSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Craigavon
    British
    CHARTERHOUSE FINANCIAL NEGOTIATIONS LIMITED11. Jan. 200526. Jan. 2006AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Craigavon
    Northern IrelandBritish
    BALTIC CONSTRUCTION (N.I.) CO LTD26. Jan. 200626. Jan. 2006AufgelöstSekretär
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0