Dorothy May KANE - Seite 176
Natürliche Person
Titel | Mrs |
---|---|
Vorname | Dorothy |
Zweites Vornamen | May |
Nachname | KANE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 48 |
Zurückgetreten | 9443 |
Gesamt | 9491 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE RAILWAY BAR (LURGAN) LIMITED | 11. Jan. 2006 | 11. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
PHASE 2 PROPERTY LIMITED | 11. Jan. 2006 | 11. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
J. M. ELECTRICS CO. LTD | 11. Jan. 2006 | 11. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
HF HYDRAULICS LTD | 11. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
STRAMORE ESTATES LIMITED | 09. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
PHOENIX WORKS MANAGEMENT SERVICES LTD | 09. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
MCCOTTER & CO LTD | 09. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
PAUL MCALISTER ARCHITECTS LIMITED | 09. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
FAIRFIELD INTERIORS LIMITED | 09. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
RED BRANCH LTD | 09. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
IN-LINE ENVIRONMENTAL LTD | 09. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
A S HOUSES LIMITED | 09. Jan. 2006 | 09. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
ROSEBANK DAIRIES LIMITED | 09. Dez. 2005 | 09. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British | ||
ROSEBANK DAIRIES LIMITED | 09. Dez. 2005 | 09. Jan. 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL | Northern Ireland | British |
DONVET LIMITED | 05. Jan. 2006 | 05. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
S.E.P.H. LIMITED | 05. Jan. 2006 | 05. Jan. 2006 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
HAMILL CONSTRUCTION LTD | 05. Jan. 2006 | 05. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
BALLYDOO LIMITED | 14. Okt. 2005 | 05. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
BALLYDOO LIMITED | 14. Okt. 2005 | 05. Jan. 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
DRUMART PROPERTIES LIMITED | 19. Dez. 2005 | 05. Jan. 2006 | Verwalter bestellt | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British | ||
DRUMART PROPERTIES LIMITED | 19. Dez. 2005 | 05. Jan. 2006 | Verwalter bestellt | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | Northern Ireland | British |
BIG PICTURE DEVELOPMENTS LTD | 03. Jan. 2006 | 03. Jan. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
CALLAN CONSTRUCTION LIMITED | 25. Okt. 2005 | 30. Dez. 2005 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
CALLAN CONSTRUCTION LIMITED | 25. Okt. 2005 | 30. Dez. 2005 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
MIDHILL LIMITED | 09. Dez. 2005 | 28. Dez. 2005 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British | ||
MIDHILL LIMITED | 09. Dez. 2005 | 28. Dez. 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL | Northern Ireland | British |
MONSOON DEVELOPMENTS LIMITED | 21. Juni 2005 | 23. Dez. 2005 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
MONSOON DEVELOPMENTS LIMITED | 21. Juni 2005 | 23. Dez. 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British |
DORVIC CARAVANS LTD | 22. Dez. 2005 | 22. Dez. 2005 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British | ||
THE BUTCHER SHOP CO. LTD | 22. Dez. 2005 | 22. Dez. 2005 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British | ||
EDEN PRINTING INKS LTD | 22. Dez. 2005 | 22. Dez. 2005 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British | ||
T & C ENTERPRISES (N.I.) LIMITED | 22. Dez. 2005 | 22. Dez. 2005 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | ||
KENNETH BROWN FINANCIAL SERVICES LTD | 22. Dez. 2005 | 22. Dez. 2005 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British | ||
M.H. KENNEDY CONTRACTS LTD | 22. Dez. 2005 | 22. Dez. 2005 | Aufgelöst | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British | ||
LISBANE CONSULTANTS LTD | 21. Dez. 2005 | 21. Dez. 2005 | Aktiv | Sekretär | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Craigavon | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0