Kevin BREWER - Seite 41
Natürliche Person
Titel | Dr |
---|---|
Vorname | Kevin |
Nachname | BREWER |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 7377 |
Gesamt | 7384 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L E CAWLEY LIMITED | 02. Okt. 2001 | 02. Okt. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
M & G DEVELOPMENTS (WOLVERHAMPTON) LIMITED | 01. Okt. 2001 | 01. Okt. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
STRONGBOX LIMITED | 01. Okt. 2001 | 01. Okt. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
DCE SOLUTIONS LIMITED | 01. Okt. 2001 | 01. Okt. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
LAKESIDE BUILDING SERVICES LIMITED | 28. Sept. 2001 | 28. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
WEE CREATIVE COMPANY LIMITED | 27. Sept. 2001 | 27. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
GLOBAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 17. Aug. 2001 | 27. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
TANTRA ASSETS LIMITED | 27. Sept. 2001 | 27. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
HART RECRUITMENT LIMITED | 26. Sept. 2001 | 26. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
NEW POSSIBILITIES LIMITED | 26. Sept. 2001 | 26. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ABSOLUTE RECRUIT LTD | 26. Sept. 2001 | 26. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MFS TRANSPORT LIMITED | 25. Sept. 2001 | 25. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
BRADFORD BUILDING (ESSEX) LIMITED | 25. Sept. 2001 | 25. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
INDUSTRIAL MOTORS AND GEARS LIMITED | 25. Sept. 2001 | 25. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MOTORCLIMATE UK LIMITED | 25. Sept. 2001 | 25. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CODE 27 LIMITED | 25. Sept. 2001 | 25. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
LEICESTER PURCHASING SOLUTIONS LIMITED | 16. Mai 2000 | 25. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
TELESAVE LIMITED | 24. Sept. 2001 | 24. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
JULIAN SWIFT LIMITED | 24. Sept. 2001 | 24. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
W.I.P. INTERNATIONAL LIMITED | 24. Sept. 2001 | 24. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
GOLF RANGE NEWS LIMITED | 21. Sept. 2001 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
P.P. LIFT CHAINS LIMITED | 21. Sept. 2001 | 21. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
FOURPENNY LIMITED | 21. Sept. 2001 | 21. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
M.I.O. TRADING LIMITED | 21. Sept. 2001 | 21. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CAR CARE BODYWORKS LIMITED | 21. Sept. 2001 | 21. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
LIGHTPRO LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
AQUA PRODUCTS LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ORTUS DESIGN LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
FENTONS TAXI RENTALS LIMITED | 19. Sept. 2001 | 19. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
WEST COURT BEXHILL FREEHOLDERS LIMITED | 19. Sept. 2001 | 19. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
W T SYSTEMS LIMITED | 19. Sept. 2001 | 19. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
DE VERE ASSOCIATES LIMITED | 19. Sept. 2001 | 19. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
KENTECH ELECTRONIC PRODUCTION LIMITED | 18. Sept. 2001 | 18. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | British | ||
EMPLOYMENT RELATIONS SERVICES LIMITED | 18. Sept. 2001 | 18. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MAYFAIR CORPORATION LIMITED | 17. Aug. 2001 | 17. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0