Kevin BREWER - Seite 90
Natürliche Person
Titel | Dr |
---|---|
Vorname | Kevin |
Nachname | BREWER |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 7377 |
Gesamt | 7384 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE SERVICE WORKSHOP LIMITED | 21. Sept. 1999 | 14. Okt. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
OAKMEAD CAPITAL LIMITED | 21. Sept. 1999 | 21. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CORNERSTONE COMMUNICATIONS LIMITED | 21. Sept. 1999 | 02. März 2000 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
PAUL HARRISON LIMITED | 20. Sept. 1999 | 20. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
P.J ACCIDENT ASSISTANCE LIMITED | 20. Sept. 1999 | 20. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ORGASMIC LIMITED | 17. Sept. 1999 | 17. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
DIGITAL LEMON LIMITED | 17. Sept. 1999 | 17. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
INTERNATIONAL INSTITUTE OF METALFORMING | 16. Sept. 1999 | 16. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
NORMANDY MENUISERIE LIMITED | 15. Sept. 1999 | 15. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MIKADO PACKAGING LIMITED | 15. Sept. 1999 | 15. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
INDUSTRIAL OPTIMIZERS (UK) LIMITED | 15. Sept. 1999 | 15. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ELEGANT-LIFESTYLE LTD. | 14. Sept. 1999 | 14. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
GORGEOUS FASHIONS LIMITED | 13. Sept. 1999 | 13. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
FORK LIFT TRADERS LIMITED | 13. Sept. 1999 | 13. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ADAM MYERS LIMITED | 13. Sept. 1999 | 13. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
GSM DISTRIBUTION LIMITED | 13. Sept. 1999 | 13. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
K. & S. ROURKE PHOTO IMAGING LIMITED | 10. Sept. 1999 | 10. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
COMPUTERISED CUTTING TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | 10. Sept. 1999 | 10. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ENERGIA CONSULTANTS LIMITED | 10. Sept. 1999 | 10. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | British | ||
PENSTOWE LEISURE LIMITED | 09. Sept. 1999 | 09. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
BRILLIANT PUBLICATIONS LIMITED | 09. Sept. 1999 | 09. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CONTRACT FURNISHING LIMITED | 09. Sept. 1999 | 09. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SMART GDS MARKETING LIMITED | 09. Sept. 1999 | 09. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
BHAGI LIMITED | 07. Sept. 1999 | 07. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
NATIONWIDE TECHNOLOGIES LIMITED | 07. Sept. 1999 | 23. Nov. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
PORTERGATE RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED | 07. Sept. 1999 | 07. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
P.P.K. DEVELOPMENTS LTD | 07. Sept. 1999 | 07. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
VEND-IT LIMITED | 07. Sept. 1999 | 07. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ONCE UPON A TIME ACTIVATION LIMITED | 07. Sept. 1999 | 07. Sept. 1999 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
OXFORD BUSINESS SUPPORT SERVICES LIMITED | 07. Sept. 1999 | 07. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CHAUFFEUR RAMSGATE LIMITED | 06. Sept. 1999 | 06. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CABCALL CENTRE LIMITED | 06. Sept. 1999 | 06. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
CHAUFFEUR WESTGATE LIMITED | 06. Sept. 1999 | 06. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
PERFORMING TEAMS (OFFSHORE) LIMITED | 03. Sept. 1999 | 03. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
K J PROPERTIES (UK) LIMITED | 03. Sept. 1999 | 03. Sept. 1999 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0