BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Page 136
Dirigeant de société
Nom | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 4879 |
Total | 4881 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
BRIDGE CAR COMPANY LIMITED | 05 juil. 1991 | 05 juil. 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
READYEARN LIMITED | 20 juin 1991 | 03 juil. 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GRACO GROUP LIMITED | 28 mai 1991 | 01 juil. 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J & B PROMOTIONS DISTRIBUTION LIMITED | 03 juin 1991 | 30 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DEE - SCAN LIMITED | 27 juin 1991 | 27 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
J.S.M. FINANCE LIMITED | 21 janv. 1991 | 27 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CHESTER INTERNATIONAL LIMITED | 27 juin 1991 | 27 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STRATEGY THREE LIMITED | 10 avr. 1991 | 27 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SIMPLER SHOPPING LIMITED | 27 juin 1991 | 27 juin 1991 | Liquidation | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE GRANARIES RESIDENTS COMPANY LIMITED | 20 juin 1991 | 24 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
STAFFORD GLAZING SERVICES LIMITED | 24 juin 1991 | 24 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAN DO BUSINESS SERVICES LIMITED | 21 juin 1991 | 21 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
A.N. FASHIONS LIMITED | 20 juin 1991 | 20 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ACTIONSTRIDE LIMITED | 22 mai 1991 | 20 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
LL SHELL LIMITED | 19 juin 1991 | 19 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HUNCOAT BEEF COMPANY LIMITED | 22 mai 1991 | 18 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RISHTON BEEF COMPANY LIMITED | 04 juin 1991 | 18 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FENCE BEEF COMPANY LIMITED | 04 juin 1991 | 18 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GISBURN BEEF COMPANY LIMITED | 22 mai 1991 | 18 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PRIMEPURPOSE LIMITED | 04 juin 1991 | 18 juin 1991 | Liquidation | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CONNOR LIMITED | 14 juin 1991 | 14 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
SHAKO SITE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 16 mai 1991 | 14 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CASTLE MILL PRINT LIMITED | 12 juin 1991 | 12 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
GAMAR TELECOMMUNICATIONS (UK) LIMITED | 15 mai 1991 | 11 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
F. R. ELSWOOD LIMITED | 04 juin 1991 | 04 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRETBY ANALYTICAL CONSULTANTS LIMITED | 04 juin 1991 | 04 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TITAN METAL FABRICATIONS LIMITED | 03 juin 1991 | 03 juin 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
INSURANCE AND LEGAL SERVICES LIMITED | 17 mai 1991 | 30 mai 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DIGBITS LIMITED | 29 mai 1991 | 29 mai 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
U.K. HEAT TECHNOLOGY LIMITED | 28 mai 1991 | 28 mai 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CROSSLEY CARPETS LIMITED | 28 mai 1991 | 28 mai 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
TOGETHER PERSONAL FINANCE LIMITED | 22 mai 1991 | 22 mai 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE PRINTED WORD BUSINESS AND PROMOTIONAL PRINT LIMITED | 21 mai 1991 | 21 mai 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DENE CORPORATION LIMITED | 21 mai 1991 | 21 mai 1991 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
K. DOUGHTY PLASTERERS LIMITED | 21 mai 1991 | 21 mai 1991 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0