BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Page 44
Dirigeant de société
| Nom | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Est un dirigeant de société | Oui |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 4879 |
| Total | 4881 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| GENAMIK LIMITED | 27 juin 1997 | 27 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SOUTH EASTERN CABLE CONTRACTORS LIMITED | 27 juin 1997 | 27 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SAFETECH LTD | 26 juin 1997 | 26 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PROJECT SURVEYING LIMITED | 25 juin 1997 | 25 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CONTRACTCHOICE LIMITED | 23 juin 1997 | 26 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SEATRACK LIMITED | 23 juin 1997 | 10 juil. 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BONNETHILL DEVELOPMENTS LIMITED | 23 juin 1997 | 23 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EARTH SHIFT LIMITED | 23 juin 1997 | 04 août 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ONE VOICE MUSIC LIMITED | 23 juin 1997 | 23 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STOP SEARCHING.COM LIMITED | 23 juin 1997 | 08 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LINCOLN PROTEINS LIMITED | 20 juin 1997 | 20 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EWHURST CONTROL SERVICES LIMITED | 20 juin 1997 | 20 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TILETECH LIMITED | 20 juin 1997 | 20 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| R P B SITEXCEL LIMITED | 20 juin 1997 | 20 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ACCOUNTANCY BASED COMPUTING LIMITED | 19 juin 1997 | 19 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SUTHERLAND EDUCATION LTD | 18 juin 1997 | 18 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE HANCOCK PARTNERSHIP LIMITED | 17 juin 1997 | 17 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CLEE BECK (TECHNICAL SERVICES) LIMITED | 17 juin 1997 | 17 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| AJMD CONSULTING LTD | 13 juin 1997 | 13 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MISSIONPHASE LIMITED | 13 juin 1997 | 21 juil. 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FLINTNINE FASTENERS LIMITED | 13 juin 1997 | 13 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SITEPRINT LIMITED | 13 juin 1997 | 30 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SET MARKETING SERVICES LIMITED | 13 juin 1997 | 13 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ACORN FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED | 12 juin 1997 | 12 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HERTSMERE BOROUGH FUNERAL & MEMORIAL SERVICES LIMITED | 12 juin 1997 | 12 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DAVE BARRON CARAVANS LIMITED | 12 juin 1997 | 19 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WELLINGS GROUP LIMITED | 12 juin 1997 | 12 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| COBWEBS OF LOCKERBIE LIMITED | 12 juin 1997 | 12 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| S C S MAINTENANCE LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| G & B MCKIE ENGINEERING RESOURCES LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BERI MARKETING CONSULTANCY LIMITED | 11 juin 1997 | 18 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ALLWEATHER REFRIGERATION LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NINE THE FIRS PROPERTY MANAGEMENT CO. LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JACK MORTON EUROPE LIMITED | 10 juin 1997 | 11 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| A.D.G. HOME CENTER LIMITED | 10 juin 1997 | 10 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0