BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Page 18
Dirigeant de société
| Nom | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Est un dirigeant de société | Oui |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 4879 |
| Total | 4881 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| TIDALWAVE INTERNATIONAL LIMITED | 03 juin 1998 | 03 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LEXON (GB) LIMITED | 03 juin 1998 | 03 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LEECO BUILDING SERVICES LIMITED | 03 juin 1998 | 03 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| JOINT LEARNING PARTNERSHIP LIMITED | 03 juin 1998 | 03 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| KNOWLEDGE GARDEN CONSULTING LIMITED | 03 juin 1998 | 03 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TWISTER INTERACTIVE LIMITED | 03 juin 1998 | 03 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ARTISAN FABRICS LIMITED | 02 juin 1998 | 02 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| KASHMIR FORUM | 02 juin 1998 | 02 juin 1998 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| J. BROOKS DESIGNS LIMITED | 02 juin 1998 | 02 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ANTISOCIAL SOFTWARE LIMITED | 02 juin 1998 | 02 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WRIGHT WRIGHT WRIGHT LIMITED | 02 juin 1998 | 02 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| W H SINGLETON LIMITED | 29 mai 1998 | 29 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ALAN J BRADLEY & SONS LIMITED | 29 mai 1998 | 29 mai 1998 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BELL CHOICE LIMITED | 29 mai 1998 | 18 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MULTI SAVE WAREHOUSE LIMITED | 29 mai 1998 | 29 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| P.B.SOLUTIONS LIMITED | 29 mai 1998 | 29 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ALDEN DEVELOPMENTS (NW) LIMITED | 29 mai 1998 | 15 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MOSSWOOD PROPERTIES LIMITED | 29 mai 1998 | 19 août 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WARRINGTON BUILDERS AND DEVELOPERS LIMITED | 29 mai 1998 | 11 juin 1998 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PERCALF LIMITED | 29 mai 1998 | 29 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TRADEACTION LIMITED | 29 mai 1998 | 11 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PARAMOUNT PRINT GROUP LIMITED | 29 mai 1998 | 07 juil. 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SONICVISION LIMITED | 29 mai 1998 | 10 juin 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CLIMATE CONSTRUCTION SERVICES LIMITED | 28 mai 1998 | 28 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STOMPERS FOOTWEAR LIMITED | 28 mai 1998 | 28 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SPECTRAL IMAGE LIMITED | 28 mai 1998 | 28 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BLACK OPAL LIMITED | 28 mai 1998 | 28 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LIVERPOOL AVIATION SERVICES LIMITED | 27 mai 1998 | 27 mai 1998 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| C.B.S. BUILDING AND LANDSCAPING LIMITED | 27 mai 1998 | 27 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SYSMEDIA LIMITED | 27 mai 1998 | 27 mai 1998 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| R & B SERVICES (OFFICE SUPPORT) LIMITED | 27 mai 1998 | 27 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| APPLIANCE SERVICES (A-U-L) LIMITED | 21 mai 1998 | 21 mai 1998 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CLARENDON ACCOUNTING SOLUTIONS LIMITED | 21 mai 1998 | 21 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BONTHORPE CONSTRUCTION LIMITED | 21 mai 1998 | 21 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TOURISM DESTINATION SERVICES LIMITED | 21 mai 1998 | 21 mai 1998 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0