BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Page 99
Dirigeant de société
| Nom | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| Est un dirigeant de société | Oui |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 4879 |
| Total | 4881 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| MANLEY-GOLD DEVELOPMENTS LIMITED | 28 juin 1994 | 28 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DIAMOND SHOPFITTING LIMITED | 28 juin 1994 | 28 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FLATHOLD LIMITED | 28 juin 1994 | 28 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| OLIAN LIMITED | 28 juin 1994 | 28 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| T.I.M. CO. (TRADING) LTD | 27 juin 1994 | 24 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PAINT PLANT UK LIMITED | 27 juin 1994 | 27 juin 1994 | Liquidation | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PETER N HEWITT ASSOCIATES LIMITED | 23 juin 1994 | 23 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SIDLOW BROTHERS CONSTRUCTION LIMITED | 22 juin 1994 | 22 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SELECTPACK LIMITED | 22 juin 1994 | 04 août 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| A C PRICE (ENGINEERING) LIMITED | 22 juin 1994 | 22 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GREY SPACE LIMITED | 20 juin 1994 | 20 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WILBURY INTERNATIONAL LIMITED | 20 juin 1994 | 20 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WILBURY TRADING (UK) LIMITED | 20 juin 1994 | 20 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BRADLEY ROYLE LIMITED | 20 juin 1994 | 29 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ADLINGTON PLASTICS LIMITED | 16 juin 1994 | 16 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PERRY NICHOLLS LIMITED | 16 juin 1994 | 16 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INSITU OFFICE SEATING LIMITED | 16 juin 1994 | 20 juil. 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| L.B.S. THERMOFORM LIMITED | 16 juin 1994 | 16 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ICE ENERGY HEAT PUMPS LIMITED | 15 juin 1994 | 15 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE NORMANHURST HOTEL LIMITED | 14 juin 1994 | 14 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| NORTHERN MOTORS LIMITED | 14 juin 1994 | 14 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BEECHWOOD REALISATIONS LIMITED | 14 juin 1994 | 14 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE HOME CARETAKERS LIMITED | 13 juin 1994 | 13 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GORDON'S TYRES (LEEDS) LIMITED | 13 juin 1994 | 13 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CLEARSCHEME LIMITED | 13 juin 1994 | 20 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HAMLET (UK) LIMITED | 09 juin 1994 | 20 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PARAMOUNT STERLING ASSOCIATES LTD. | 09 juin 1994 | 12 juil. 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CENTURY HOUSE (MANCHESTER) LIMITED | 08 juin 1994 | 08 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ANDREW MOORE & ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LIMITED | 08 juin 1994 | 09 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CARE - KNIGHT LIMITED | 07 juin 1994 | 08 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STMCO LTD. | 06 juin 1994 | 07 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CREDITLOGIC LIMITED | 06 juin 1994 | 18 août 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| T G S ASSOCIATES LIMITED | 03 juin 1994 | 24 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| J F LORD LIMITED | 02 juin 1994 | 30 juin 1994 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE MALMAISON HOTEL (MANCHESTER) LIMITED | 01 juin 1994 | 01 juin 1994 | Active | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0