Caroline Jane SELLERS - Page 3
Personne physique
Titre | Mrs |
---|---|
Prénom | Caroline |
Deuxième prénom | Jane |
Nom de famille | SELLERS |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 75 |
Démissionné | 47 |
Total | 122 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGNEY SHOPPING CENTRE LTD | 18 mars 1999 | Converti / Fermé | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 England | British | |||
R.S.CAPE LIMITED | 18 mars 1999 | Converti / Fermé | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | |||
FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED | 18 mars 1999 | Converti / Fermé | Secrétaire | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | British | |||
FIESTA TRAVEL LIMITED | 18 mars 1999 | Converti / Fermé | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | |||
CWS (NO 2) LIMITED | 18 mars 1999 | Dissoute | Secrétaire | c/o Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House United Kingdom | British | |||
MEMBER A (4) LIMITED | 23 juin 2008 | 31 mars 2025 | Active | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 England | British | ||
CO-OPERATIVE BRANDS LIMITED | 01 déc. 2004 | 31 mars 2025 | Active | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
CWS (NO 1) LIMITED | 18 mars 1999 | 31 mars 2025 | Active | Secrétaire | c/o Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House United Kingdom | British | ||
THE CO-OPERATIVE TRUST CORPORATION LIMITED | 25 juil. 2007 | 21 oct. 2015 | Active | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
CO-OPERATIVE LEGAL SERVICES LIMITED | 13 avr. 2006 | 21 oct. 2015 | Active | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
CO-OP TRAVEL LIMITED | 12 nov. 2003 | 30 oct. 2014 | Active | Secrétaire | Warwick Technology Park, Gallows Hill CV34 6DA Warwick Co-Operative House Warwickshire United Kingdom | British | ||
RLJ CONSULTANCY LIMITED | 05 mars 2007 | 30 sept. 2014 | Active | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | ||
GOALTIME LIMITED | 05 déc. 2006 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Assistant Secretary | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | |
GRAHAM MORRIS LIMITED | 30 juin 2006 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
DEANTECH LIMITED | 30 juin 2006 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
ANDREW BASS LIMITED | 01 nov. 2004 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
ACCRUEDIRECT LIMITED | 04 oct. 2004 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
J. WALL PHARMACY LIMITED | 10 sept. 2004 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 England | British | ||
COASTAL PHARMACY LIMITED | 13 févr. 2004 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
SOCIETY SPECIALISTS LIMITED | 13 févr. 2004 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 England | British | ||
NEW CENTURY CHEMISTS LIMITED | 13 févr. 2004 | 30 sept. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 England | British | ||
BROADOAK FARMING LIMITED | 18 mars 1999 | 02 août 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
BROADOAK LIMITED | 18 mars 1999 | 02 août 2014 | Dissoute | 1803 | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | |
MERSE AGRICULTURAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 18 mars 1999 | 02 août 2014 | Dissoute | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | ||
BROADOAK COUNTRYSIDE LIMITED | 18 mars 1999 | 02 août 2014 | Dissoute | Secrétaire | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | British | ||
ENSEMBLE CLOTHING LIMITED | 10 janv. 2002 | 23 nov. 2012 | Dissoute | Secrétaire | PO BOX 53 New Century House M60 4ES Manchester | British | ||
ZOOM FLIGHTS LIMITED | 14 sept. 2004 | 01 oct. 2011 | Dissoute | Secrétaire | New Century House Manchester M60 4ES | British | ||
WIND DOWN 123 LIMITED | 22 avr. 2009 | 28 août 2009 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | |
ALLDAYS FINANCE LIMITED | 20 mai 2006 | 10 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | ||
SUTHERLANDS GARAGE (BROADFORD) LIMITED | 24 avr. 2007 | 27 oct. 2007 | Converti / Fermé | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | ||
GORDON DAVIS(CHEMISTS)LTD | 30 juin 2006 | 24 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | ||
T.G.CONIBEAR(CHEMIST)LIMITED | 01 mai 2007 | 19 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | ||
TCG CARD SERVICES LIMITED | 30 juil. 2002 | 01 oct. 2007 | Converti / Fermé | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | ||
MAYBERRY & MORRIS LTD | 01 mai 2007 | 27 sept. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British | ||
BAGS OF FASHION LIMITED | 17 juin 2005 | 19 sept. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 1 Gale Close Littleborough OL15 9EJ Rochdale Lancashire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0