BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Pagina 78
Dirigente societario
| Nome | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| È un dirigente societario | Sì |
| Incarichi | |
| Attivo | 1 |
| Inattivo | 1 |
| Dimesso | 4879 |
| Totale | 4881 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| VELCOM CONSULTANTS LIMITED | 13 nov 1995 | 14 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| POWER PROMOTIONS LIMITED | 13 nov 1995 | 14 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CONSORTIUM FOR AUTOMOTIVE REGISTRATION SERVICES (QUALITY ASSURANCE) LIMITED | 10 nov 1995 | 10 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SAFETY MEDIA LTD | 10 nov 1995 | 13 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WESTMORLAND SIGNS INTERNATIONAL LIMITED | 09 nov 1995 | 10 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE HYNDBURN CLINIC OF OSTEOPATHY LTD | 09 nov 1995 | 10 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| IPEC LIMITED | 08 nov 1995 | 09 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LOOK FRESH.COM LIMITED | 08 nov 1995 | 18 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| C.F. ROBERTS (HOLDINGS) LIMITED | 08 nov 1995 | 05 gen 1996 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CORPORATE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 07 nov 1995 | 08 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BERBRIDGE ROOFING COMPANY LIMITED | 07 nov 1995 | 08 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RIVENPINE PLC | 07 nov 1995 | 05 gen 1996 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ROCKBARR LIMITED | 07 nov 1995 | 08 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| QUANTUM MICROPONENTS LIMITED | 07 nov 1995 | 08 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| A. & A. CONSULTING LIMITED | 07 nov 1995 | 08 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SABIO (WS) LIMITED | 07 nov 1995 | 08 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ASPEN WOODWORK LIMITED | 07 nov 1995 | 08 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LARWOOD LIMITED | 02 nov 1995 | 03 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| EUROPEAN INTERIOR TECHNOLOGIES LIMITED | 02 nov 1995 | 03 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GPEP DESIGNS LIMITED | 02 nov 1995 | 03 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FORUM DESIGN & MANUFACTURING LIMITED | 02 nov 1995 | 03 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TECHNICAL DOCUMENT SERVICES LIMITED | 02 nov 1995 | 03 nov 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BELSTANE MARKETING LIMITED | 31 ott 1995 | 12 dic 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CASEY'S OUTDOOR LEISURE LIMITED | 31 ott 1995 | 01 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SURFACE RESTORATION LIMITED | 31 ott 1995 | 01 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LINKING ESTATES LIMITED | 31 ott 1995 | 12 gen 1996 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| TRADE RESERVE LIMITED | 31 ott 1995 | 13 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RYAN LAND COMPANY LIMITED | 31 ott 1995 | 01 nov 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SOLENT OIL TOOLS LTD | 31 ott 1995 | 18 gen 1996 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HARRISCOM LIMITED | 27 ott 1995 | 31 ott 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BRAMHALL BUILDING CONSULTANTS LIMITED | 27 ott 1995 | 31 ott 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HEATON (EXPORT & MARKETING) LIMITED | 27 ott 1995 | 31 ott 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ABIFRAN LIMITED | 25 ott 1995 | 26 ott 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| GREENWOOD SOAR IP LIMITED | 25 ott 1995 | 26 ott 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MOUNTAIN ASH CARE GROUP LIMITED | 25 ott 1995 | 26 ott 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0