BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Pagina 91
Dirigente societario
| Nome | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
|---|---|
| È un dirigente societario | Sì |
| Incarichi | |
| Attivo | 1 |
| Inattivo | 1 |
| Dimesso | 4879 |
| Totale | 4881 |
Incarichi
| Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| H & C ASSOCIATES LIMITED | 28 feb 1995 | 01 mar 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SUPERDEC TRADE PAINTS LIMITED | 27 feb 1995 | 28 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| IRLAM TRUCK AND TANKER SPARES LIMITED | 27 feb 1995 | 03 mar 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| B.G. ELVINS LIMITED | 27 feb 1995 | 28 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| STATIONTRADE LIMITED | 27 feb 1995 | 06 mar 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| HI-FI CLUB LIMITED | 27 feb 1995 | 28 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| INTERNATIONAL LOGISTICS GROUP LIMITED | 27 feb 1995 | 06 apr 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SEAWAY SECURITY SERVICES LIMITED | 27 feb 1995 | 13 mar 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CHARNIC ENGINEERING LIMITED | 27 feb 1995 | 28 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| AVANT (BBH) LIMITED | 27 feb 1995 | 01 mag 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| SPECIALISED SURFACE COATINGS LIMITED | 27 feb 1995 | 28 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| B.V.S. LIMITED | 27 feb 1995 | 28 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| MIKE CO 3 LIMITED | 22 feb 1995 | 06 apr 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| FASHIONBREAK LIMITED | 22 feb 1995 | 23 mar 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ST LUKE'S HOSPICE TRADING LIMITED | 21 feb 1995 | 02 mar 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PAUL FRANCIS PHOTOGRAPHY LIMITED | 21 feb 1995 | 22 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| LEISURECHAIN LIMITED | 21 feb 1995 | 23 mar 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| C L G (GREAT BRITAIN) LIMITED | 21 feb 1995 | 22 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| VEHICLE INSPECTION PROFESSIONALS LIMITED | 20 feb 1995 | 21 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BRADLEY CONSULTING LIMITED | 17 feb 1995 | 20 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 17 feb 1995 | 20 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| D & E WILSON & SONS LIMITED | 17 feb 1995 | 20 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PORTFOLIO DISPLAY LIMITED | 17 feb 1995 | 20 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| WILLIAM ALLWOOD & COMPANY LIMITED | 15 feb 1995 | 16 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ANGLO LEATHER CRAFT LIMITED | 15 feb 1995 | 16 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| DANOWEN (DUCTWORK SERVICES) LIMITED | 14 feb 1995 | 15 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE REMUNERATION PRACTICE LIMITED | 14 feb 1995 | 15 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| ACCESSTRIAL LIMITED | 14 feb 1995 | 13 mar 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| R. LEWTAS SHOPFITTERS LIMITED | 14 feb 1995 | 20 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| BOO DESIGNS LIMITED | 14 feb 1995 | 10 mar 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| THE ORIGINAL BILL POSTERS COMPANY LIMITED | 13 feb 1995 | 14 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| CIRCLE CONTROL & DESIGN SYSTEMS LIMITED | 13 feb 1995 | 14 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| RAVETTE PUBLISHING LIMITED | 10 feb 1995 | 01 mag 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| PREMIERBLEND LIMITED | 10 feb 1995 | 24 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
| VENTUREBREAK LIMITED | 09 feb 1995 | 23 mar 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0