BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED - Pagina 92
Dirigente societario
Nome | BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 1 |
Inattivo | 1 |
Dimesso | 4879 |
Totale | 4881 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
B.J. BARKWELL & SONS LIMITED | 16 gen 1995 | 23 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PAUL FRANCIS PHOTOGRAPHY LIMITED | 21 feb 1995 | 22 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
C L G (GREAT BRITAIN) LIMITED | 21 feb 1995 | 22 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
VEHICLE INSPECTION PROFESSIONALS LIMITED | 20 feb 1995 | 21 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 17 feb 1995 | 20 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D & E WILSON & SONS LIMITED | 17 feb 1995 | 20 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PORTFOLIO DISPLAY LIMITED | 17 feb 1995 | 20 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BRADLEY CONSULTING LIMITED | 17 feb 1995 | 20 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
R. LEWTAS SHOPFITTERS LIMITED | 14 feb 1995 | 20 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WILLIAM ALLWOOD & COMPANY LIMITED | 15 feb 1995 | 16 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ANGLO LEATHER CRAFT LIMITED | 15 feb 1995 | 16 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DANOWEN (DUCTWORK SERVICES) LIMITED | 14 feb 1995 | 15 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE REMUNERATION PRACTICE LIMITED | 14 feb 1995 | 15 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
WYNNSTAY COUNTRY FARMSTOCK LIMITED | 31 gen 1995 | 15 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PETER MARWOOD LIMITED | 13 gen 1995 | 15 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CIRCLE CONTROL & DESIGN SYSTEMS LIMITED | 13 feb 1995 | 14 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE ORIGINAL BILL POSTERS COMPANY LIMITED | 13 feb 1995 | 14 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ASSOCIATED TOOLMAKERS LIMITED | 23 gen 1995 | 14 feb 1995 | Liquidazione | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
THE CARE TEAM LIMITED | 09 feb 1995 | 10 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
FORWARDCHAIN LIMITED | 16 gen 1995 | 09 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
CLYMAC LIMITED | 07 feb 1995 | 08 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
PURPOSETHEME LIMITED | 31 gen 1995 | 08 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
D.K. DEVELOPMENTS LIMITED | 07 feb 1995 | 08 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RECORDQUEST LIMITED | 30 gen 1995 | 08 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
POWELL MASONRY LTD. | 03 feb 1995 | 07 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
DAWTON ENGINEERS LIMITED | 03 feb 1995 | 06 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
C T S MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 03 feb 1995 | 06 feb 1995 | Liquidazione | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ADZE-TECH LIMITED | 31 gen 1995 | 01 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
ALBANY CONTINUATION | 17 nov 1994 | 01 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BAILEY INTERNATIONAL STEEPLEJACK COMPANY LIMITED | 04 nov 1994 | 01 feb 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
BERTRAM SHEPPARD LIMITED | 31 gen 1995 | 01 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
MARTIN CONNELLY LIMITED | 31 gen 1995 | 01 feb 1995 | Sciolta | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
V.J. DONEGAN & CO. (PLANT) LIMITED | 30 gen 1995 | 31 gen 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
HUSKY PROPERTIES LIMITED | 30 gen 1995 | 31 gen 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
RADICAL SERVICES LIMITED | 27 gen 1995 | 30 gen 1995 | Attiva | Segretario nominato | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0