Howard THOMAS - Seite 108
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Howard |
Nachname | THOMAS |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 7852 |
Gesamt | 7859 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANCED CONTROLS & MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | 17. Jan. 2002 | 17. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DIXONBAXI LIMITED | 17. Jan. 2002 | 17. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ENVIRON (SUNLEY) LIMITED | 17. Jan. 2002 | 17. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ECOM MEDIA UK LIMITED | 16. Jan. 2002 | 16. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
KOSAR LIMITED | 16. Jan. 2002 | 16. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
AMIKRA LIMITED | 16. Jan. 2002 | 16. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
EXIGO COMMUNICATIONS LTD. | 16. Jan. 2002 | 16. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
KIRKWOOD ESTATES LIMITED | 16. Jan. 2002 | 16. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PRIME RESIDENTIAL LIMITED | 17. Dez. 2001 | 14. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE SLICE FACTORY LIMITED | 14. Jan. 2002 | 14. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CHADWICK & COMPANY (MANCHESTER) LIMITED | 11. Jan. 2002 | 11. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GLENROYD ESTATES (NW) LTD | 11. Jan. 2002 | 11. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BERRY GROUP HOLDINGS LIMITED | 11. Jan. 2002 | 11. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LINCOLN HOLLAND HOLDINGS LIMITED | 10. Jan. 2002 | 10. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE TANNING PLANET LIMITED | 10. Jan. 2002 | 10. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
677TV LTD | 17. Dez. 2001 | 10. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MPT MANAGEMENT LIMITED | 10. Jan. 2002 | 10. Jan. 2002 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
H & M ENVIRONMENTAL LIMITED | 09. Jan. 2002 | 09. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WILCHAP 42 (GY) LIMITED | 09. Jan. 2002 | 09. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
HIGHTECH ENGINEERING SERVICES LIMITED | 09. Jan. 2002 | 09. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
QUOTEUS4.COM LIMITED | 09. Jan. 2002 | 09. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DICK FRANCIS.TV LIMITED | 08. März 2001 | 09. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
COSMIC PLANET PRODUCTIONS LIMITED | 08. Jan. 2002 | 08. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DENE MEWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 07. Jan. 2002 | 07. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GLOBAL TECHNOLOGY RESOURCE LIMITED | 07. Jan. 2002 | 07. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
OAKBANK FLAT MANAGEMENT COMPANY (NO.2) LIMITED | 07. Jan. 2002 | 07. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GADEBRIDGE ENTERPRISES LIMITED | 03. Jan. 2002 | 03. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
K. T. SOLUTIONS (MARK TWO) LIMITED | 03. Jan. 2002 | 03. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE FIFTH WHEEL COMPANY LIMITED | 03. Dez. 2001 | 02. Jan. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
UNIONDAY LIMITED | 11. Dez. 2001 | 01. Jan. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CORN EXCHANGE THEATRE COMPANY | 04. Jan. 2001 | 31. Dez. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SENSOR SHOES LIMITED | 28. Dez. 2001 | 28. Dez. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
TPC LEADERSHIP LTD | 03. Dez. 2001 | 27. Dez. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SHERWOOD COURT INVESTMENTS N05 LIMITED | 24. Dez. 2001 | 24. Dez. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
JAMES FISHER SUBSEA LIMITED | 24. Dez. 2001 | 24. Dez. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0