Howard THOMAS - Seite 182
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Howard |
Nachname | THOMAS |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 7852 |
Gesamt | 7859 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL FLUSH TECHNOLOGY LIMITED | 17. Juni 1996 | 17. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SPECIALISED REFRIGERATION SERVICES LIMITED | 14. Juni 1996 | 14. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LONGMOOR BARNS MANAGEMENT LIMITED | 12. Juni 1996 | 12. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
A.A.T. (UK) LIMITED | 17. Mai 1996 | 11. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LEEDS TECHNICAL DESIGN LIMITED | 11. Juni 1996 | 11. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WALK OF FAME LTD | 11. Juni 1996 | 11. Juni 1996 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GILLMAN GROUP LIMITED | 07. Juni 1996 | 07. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BRAND & HOWES (SANDON) LIMITED | 28. März 1996 | 07. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ITECH ELECTRICAL CONTRACTING LIMITED | 04. Juni 1996 | 04. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
POOKS HILL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 04. Juni 1996 | 04. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
FINCH HOUSE PROPERTIES LIMITED | 17. Mai 1996 | 04. Juni 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SPACE WATCH (U.K.) LTD. | 04. Juni 1996 | 04. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GLASSPRO LIMITED | 03. Juni 1996 | 03. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
JUNEADAM LIMITED | 20. März 1996 | 01. Juni 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
73 DISRAELI ROAD LIMITED | 31. Mai 1996 | 31. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MACK TRADING (HEATON PARK) LIMITED | 02. Mai 1996 | 30. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
HAVENFORM LIMITED | 29. Mai 1996 | 29. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
J.H.W. HODSON LIMITED | 09. Apr. 1996 | 29. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CATO STONEX LIMITED | 26. März 1996 | 29. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
COMING HOME LIMITED | 29. Mai 1996 | 29. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MAESTRO DELIGHT LIMITED | 29. Mai 1996 | 29. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
S L R (UK) LIMITED | 24. Mai 1996 | 24. Mai 1996 | In Verwaltung | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE LEADERS INSTITUTE | 23. Mai 1996 | 23. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
68 STURGES ROAD LIMITED | 23. Mai 1996 | 23. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MONAGHAN DEVELOPMENTS LIMITED | 22. Mai 1996 | 22. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GLOBAL MARITIME CONSULTANCY LIMITED | 21. Mai 1996 | 21. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LOVEUROPE DIGITAL LIMITED | 21. Mai 1996 | 21. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
3 COM PENSION SCHEME (1996) TRUSTEES LIMITED | 20. Mai 1996 | 20. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
JOHN HUGHES (STRUCTURAL ENGINEERS) LIMITED | 20. Mai 1996 | 20. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ALPHAVEST PLC | 20. Mai 1996 | 20. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CRAYMER EAST LIMITED | 12. Apr. 1996 | 19. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SILICONSPEED LIMITED | 24. Apr. 1996 | 15. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ROCKLEY HALL ESTATES LIMITED | 14. Mai 1996 | 14. Mai 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GCN CONSULTANCY LIMITED | 27. März 1996 | 14. Mai 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
B.S. PARKER & SON LIMITED | 14. Mai 1996 | 14. Mai 1996 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0