Howard THOMAS - Seite 115
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Howard |
Nachname | THOMAS |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 7852 |
Gesamt | 7859 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PET NANNY LIMITED | 18. Juli 2001 | 18. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CRM RENOVATIONS LIMITED | 18. Juli 2001 | 18. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
A.J. HIGGINSON (PRESS TOOLS) LIMITED | 18. Jan. 2001 | 18. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
AMX SERVICES LIMITED | 17. Juli 2001 | 17. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DELYN WINDOWS LIMITED | 17. Juli 2001 | 17. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CAPITAL POUNDS LIMITED | 17. Juli 2001 | 17. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WHITEHALL LANE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
FREQUENCY 3G TELECOM LIMITED | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
UNITED NATIONAL PHOTOGRAPHERS LTD | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
FREQUENCY 3G DISTRIBUTION LIMITED | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PROMOCLOTHING LIMITED | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
VEIN WORKS LIMITED | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CJ'S RECOVERY LIMITED | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE SURREY AND NORTH HANTS. VEIN CLINIC LIMITED | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MEDICAL IMAGING CONSULTANCY LIMITED | 13. Juli 2001 | 13. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
6 COMPAYNE GARDENS MANAGEMENT LIMITED | 11. Juli 2001 | 11. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SOLARTRACK SYSTEMS LIMITED | 11. Juli 2001 | 11. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
NORFOLK COUNTRY CRAFTSMEN LIMITED | 11. Juli 2001 | 11. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ABBEY TRAVEL COACH HIRE LIMITED | 11. Juli 2001 | 11. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE BUSINESS (TELFORD) LTD | 11. Juli 2001 | 11. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BIRCHBLOCK LIMITED | 28. Juni 2001 | 11. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
XAMAX CLOTHING COMPANY LIMITED | 09. Juli 2001 | 09. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
G A P SCAFFOLDING (MANCHESTER) LIMITED | 06. Juli 2001 | 06. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ORANGE BRIGHT TRADING LIMITED | 06. Juli 2001 | 06. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
J. L. HOUSING LIMITED | 06. Juli 2001 | 06. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
VECTOR STUNTS LTD | 04. Juli 2001 | 05. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BORLAND & BORLAND (LETTINGS) LIMITED | 04. Juli 2001 | 04. Juli 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
KOUCHINI TEXTILES LIMITED | 19. Juni 2001 | 03. Juli 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WHISTLEDOWN PRODUCTIONS LIMITED | 29. Juni 2001 | 29. Juni 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PEOPLEMOVERS (EAST ANGLIA) LIMITED | 29. Juni 2001 | 29. Juni 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ALLFARTHING LANE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 28. Juni 2001 | 28. Juni 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
LEEPAR LIMITED | 28. Juni 2001 | 28. Juni 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
COVENTRY ROOFING CENTRE LIMITED | 28. Juni 2001 | 28. Juni 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ASCRIP LIMITED | 23. Juni 1999 | 28. Juni 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BIG HAND ALE HOUSES LTD | 27. Juni 2001 | 27. Juni 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0