• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Howard THOMAS - Seite 88

    Natürliche Person

    Titel
    VornameHoward
    NachnameTHOMAS
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv7
    Zurückgetreten7852
    Gesamt7859

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    CAPITAL JACK LIMITED23. Jan. 200323. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    9 BRIDGEMAN TERRACE LIMITED23. Jan. 200323. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MJY LIMITED23. Jan. 200323. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WATERMARK TECHNOLOGIES LIMITED22. Jan. 200322. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SARAH CONNECTION LIMITED22. Jan. 200322. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    HELGA ENDEAVOURS LIMITED22. Jan. 200322. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    VINEYARD ENTERPRISES LIMITED22. Jan. 200322. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    2 SCHOOL GARDENS MANAGEMENT COMPANY LIMITED21. Jan. 200321. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LIME TREE COURT (LEIGH-ON-SEA) LIMITED21. Jan. 200321. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NHC PROPERTIES LIMITED17. Jan. 200321. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    KNOWBURY HOLDINGS LIMITED10. Dez. 200221. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MIDWINTERS PROPERTIES LIMITED09. Dez. 200221. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SYBAR ASSOCIATES LIMITED21. Jan. 200321. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    PARKFIELDS AND MARLBOROUGH ESTATES LIMITED09. Dez. 200221. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    132 DALYELL ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED20. Jan. 200320. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LOCKWOOD WILMSLOW LIMITED20. Jan. 200320. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ALAN WOOD LIMITED20. Jan. 200320. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    MILTON GOLF CLUB LIMITED20. Jan. 200320. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    CAMBRIDGE GOLF DEVELOPMENTS LIMITED20. Jan. 200320. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    O.W.C. FINANCE LIMITED16. Jan. 200320. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    C TILE LIMITED17. Jan. 200317. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    K. K. REAL ESTATE LIMITED17. Jan. 200317. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    NEW BOND STREET PAWNBROKERS LIMITED17. Jan. 200317. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ARGENT REHABILITATION RTW LIMITED17. Jan. 200317. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    23 ST STEPHENS AVENUE RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED16. Jan. 200316. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    O'NEIL PRINT SOLUTIONS LIMITED16. Jan. 200316. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    SONNER BUILDING MAINTENANCE LTD09. Dez. 200216. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    GLADWISH LAND SALES LIMITED15. Jan. 200315. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BOSSBETTER MANCHESTER LIMITED15. Jan. 200315. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    WR PROJECTS LIMITED15. Jan. 200315. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    ADVANCED BUILDING & ROOFING SUPPLIES LIMITED13. Jan. 200313. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    "OFF THE PAGE" LIMITED13. Jan. 200313. Jan. 2003AktivBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    BANK COTTAGE LIMITED13. Jan. 200313. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    EUROZONE NORTHERN LIMITED13. Jan. 200313. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British
    LAWNS ALIVE LIMITED13. Jan. 200313. Jan. 2003AufgelöstBevollmächtigter Sekretär
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0