Howard THOMAS - Seite 185
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Howard |
Nachname | THOMAS |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 7852 |
Gesamt | 7859 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 PEPYS ROAD MANAGEMENT LIMITED | 28. Feb. 1996 | 28. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
RHOSTYLLEN PIES LTD | 28. Feb. 1996 | 28. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE REVIVAL ART COMPANY LIMITED | 28. Feb. 1996 | 28. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SWIFT FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | 27. Feb. 1996 | 27. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
C.J. ENTERPRISES (LONDON) LIMITED | 26. Feb. 1996 | 26. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ROSERROW MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 23. Feb. 1996 | 23. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE OLD SCHOOL COURT TETBURY LIMITED | 22. Feb. 1996 | 22. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SOUTH COAST DEVELOPMENTS LIMITED | 21. Feb. 1996 | 21. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ALEXANNE LIMITED | 15. Feb. 1996 | 21. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
TAKE THAT CAR HIRE LIMITED | 22. Dez. 1995 | 20. Feb. 1996 | Liquidation | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
INVESTORS IN PROPERTY LIMITED | 16. Feb. 1996 | 16. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
YOUNG CALIBRATION LIMITED | 15. Feb. 1996 | 15. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
I T PRODUCTIONS LIMITED | 15. Feb. 1996 | 15. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ORCHARD LEISURE CLUB LIMITED | 14. Feb. 1996 | 14. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PIPATUS LIMITED | 22. Jan. 1996 | 13. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
KEW (ELECTRICAL DISTRIBUTORS) LIMITED | 07. Feb. 1996 | 07. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DSC INSULATIONS (EMMERSON LANE) LIMITED | 02. Nov. 1995 | 07. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
11 BATOUM GARDENS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 06. Feb. 1996 | 06. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MICHAEL WHITAKER FABRICS LIMITED | 05. Feb. 1996 | 05. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
G.D. GOLDING (PROPERTIES) LTD. | 02. Feb. 1996 | 02. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BRENNAND SCHOOLWEAR LIMITED | 02. Feb. 1996 | 02. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SMARTSTEAD LIMITED | 20. Dez. 1995 | 02. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
INTEGRITY 2000 | 01. Feb. 1996 | 01. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BRUNEL MEWS RESIDENTS COMPANY LIMITED | 29. Jan. 1996 | 29. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THSP LIMITED | 29. Jan. 1996 | 29. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WASHINGTON SPECSAVERS LIMITED | 26. Jan. 1996 | 26. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BLUE PENCIL MULTIMEDIA LIMITED | 26. Jan. 1996 | 26. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
R AND R INTERNATIONAL LIMITED | 25. Jan. 1996 | 25. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
A.P.M. (MANCHESTER) LIMITED | 23. Jan. 1996 | 23. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
105 LEXHAM GARDENS LIMITED | 23. Jan. 1996 | 23. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MUNSTER JOINERY (U.K.) LIMITED | 19. Jan. 1996 | 19. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
DIRECT RECRUITMENT AGENCY LTD | 19. Jan. 1996 | 19. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
STRATFORD SPECSAVERS LIMITED | 20. Dez. 1995 | 18. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
RAYMEDIA LIMITED | 17. Jan. 1996 | 17. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MCLANE EUROPE 1 LIMITED | 20. Dez. 1995 | 17. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0