Stephen MABBOTT - Seite 19
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Stephen |
Nachname | MABBOTT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 2448 |
Gesamt | 2449 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROWSTEP HOLDINGS LIMITED | 17. Apr. 1998 | 17. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
VIVERS I.T. CONSULTANTS LIMITED | 17. Apr. 1998 | 17. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SENTRY SOLUTIONS LIMITED | 07. Apr. 1998 | 17. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SEADAWN LIMITED | 03. Apr. 1998 | 17. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
THE ADVICE CENTRE FOR MORTGAGES LTD. | 03. Apr. 1998 | 17. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DAVID STARK CONSULTANTS LIMITED | 16. Apr. 1998 | 16. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CREATIVE FABRICATIONS LTD | 14. Apr. 1998 | 14. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
REDWOOD GROUP SHARE PLAN (TRUSTEES) LIMITED | 14. Apr. 1998 | 14. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ACCOUNTANTS PLUS (HAMILTON) LTD | 09. Apr. 1998 | 09. Apr. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
AP HOLDINGS (HAMILTON) LTD | 09. Apr. 1998 | 09. Apr. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
NORTEK ALUMINIUM SYSTEMS LTD. | 09. Apr. 1998 | 09. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
J & M TELECOM LIMITED | 09. Apr. 1998 | 09. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BALLINDARG BUILDINGS LTD. | 09. Apr. 1998 | 09. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
147 LEADENHALL STREET LIMITED | 09. Apr. 1998 | 09. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SCOTSTONE LIMITED | 03. Apr. 1998 | 09. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BELLMONT SOLUTIONS LIMITED | 08. Apr. 1998 | 08. Apr. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BEEMAC CONCRETE LIMITED | 03. Apr. 1998 | 08. Apr. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
VAGABOND NOMAD LIMITED | 08. Apr. 1998 | 08. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
J DAY & COMPANY LIMITED | 08. Apr. 1998 | 08. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
THISTLE STRUCTURES LIMITED | 08. Apr. 1998 | 08. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
IX LEGION LIMITED | 08. Apr. 1998 | 08. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DOUBLE JAY (SCOTLAND) LIMITED | 07. Apr. 1998 | 07. Apr. 1998 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
VONTEC IT LTD. | 06. Apr. 1998 | 06. Apr. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
A & J LOCKE JOINERS LIMITED | 06. Apr. 1998 | 06. Apr. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
MIDDLEFORD ENGINEERING PROJECTS LTD. | 06. Apr. 1998 | 06. Apr. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
MCCORMACK DEVELOPMENTS LIMITED | 06. Apr. 1998 | 06. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SEAFORTH ASSOCIATES LTD. | 06. Apr. 1998 | 06. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CELTIC ADVENTURES LIMITED | 06. Apr. 1998 | 06. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GRANTLY DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LIMITED | 03. Apr. 1998 | 06. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
COWDENBEATH AUTO CENTRE CO. LTD. | 20. Feb. 1998 | 06. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BURRELL PNEUMATICS LTD. | 03. Apr. 1998 | 03. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
INDEPENDENT LIVING SERVICES (I L S) LIMITED | 03. Apr. 1998 | 03. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
MONAX GLASS LIMITED | 02. Apr. 1998 | 02. Apr. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ABOUTSCOTLAND LTD. | 02. Apr. 1998 | 02. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BARRWOOD LIMITED | 02. Apr. 1998 | 02. Apr. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British |
Zurück2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0