Stephen MABBOTT - Seite 42
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Stephen |
Nachname | MABBOTT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 2448 |
Gesamt | 2449 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.L. PAINT AND SUPPLIES LIMITED | 03. März 1997 | 03. März 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
TONY MCMANUS LIMITED | 03. März 1997 | 03. März 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DONALD FARMS LIMITED | 03. März 1997 | 03. März 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SHETLAND MUSSELS LIMITED | 28. Feb. 1997 | 28. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ASSETTA LTD. | 28. Feb. 1997 | 28. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
LOCH THOM DISTILLERY LTD. | 27. Feb. 1997 | 27. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GENEVA MANAGEMENT UK LTD. | 27. Feb. 1997 | 27. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SALTIRE INTERIORS LIMITED | 27. Feb. 1997 | 27. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HS TRAINING LTD. | 27. Feb. 1997 | 27. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BEACHWYND LIMITED | 27. Feb. 1997 | 27. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
WHITEFRIARS LIMITED | 27. Feb. 1997 | 27. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
NETCON-X LIMITED | 27. Feb. 1997 | 27. Feb. 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
INVERKYLE LIMITED | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
INVERMONT LIMITED | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SANDY ANDERSON TRANSPORT LTD | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BON ACCORD PROJECT SERVICES LTD. | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
REALGOOD CHIP LIMITED | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BIG HOUSE CONSULTING LIMITED | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SUNFLOWER PRIVATE NURSERY LIMITED | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Gesch äftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ACCORD TECHNICAL SERVICES LTD. | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
FIFF LIMITED | 26. Feb. 1997 | 26. Feb. 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
TURNER POWER SYSTEMS LIMITED | 25. Feb. 1997 | 25. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
W & T OSLER LIMITED | 25. Feb. 1997 | 25. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BM LANDHOLDINGS LIMITED | 06. Feb. 1997 | 25. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GALLOWAY BUILDING SERVICES LIMITED | 25. Feb. 1997 | 25. Feb. 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
MARPET FABRICATIONS (1997) LTD. | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GLENACRE MANAGEMENT LIMITED | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BULLDALE MANAGEMENT LIMITED | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
MARINE DIESEL SERVICES (SCOTLAND) LTD | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CANONGATE DEVELOPMENTS LIMITED | 02. Jan. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ALBA HEALTH LIMITED | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HEXHAM MANAGEMENT LIMITED | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CALGREY LIMITED | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
VICTORIAS (LICENCE) LIMITED | 21. Feb. 1997 | 21. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
TEMPLE HOUSE CARE HOME LIMITED | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British |
Zurück2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0