• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Stephen MABBOTT - Seite 42

    Natürliche Person

    Titel
    VornameStephen
    NachnameMABBOTT
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv1
    Zurückgetreten2448
    Gesamt2449

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    A.L. PAINT AND SUPPLIES LIMITED03. März 199703. März 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    TONY MCMANUS LIMITED03. März 199703. März 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    DONALD FARMS LIMITED03. März 199703. März 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    SHETLAND MUSSELS LIMITED28. Feb. 199728. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    ASSETTA LTD.28. Feb. 199728. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    LOCH THOM DISTILLERY LTD.27. Feb. 199727. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    GENEVA MANAGEMENT UK LTD.27. Feb. 199727. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    SALTIRE INTERIORS LIMITED27. Feb. 199727. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    HS TRAINING LTD.27. Feb. 199727. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BEACHWYND LIMITED27. Feb. 199727. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    WHITEFRIARS LIMITED27. Feb. 199727. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    NETCON-X LIMITED27. Feb. 199727. Feb. 1997LiquidationBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    INVERKYLE LIMITED26. Feb. 199726. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    INVERMONT LIMITED26. Feb. 199726. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    SANDY ANDERSON TRANSPORT LTD26. Feb. 199726. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BON ACCORD PROJECT SERVICES LTD.26. Feb. 199726. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    REALGOOD CHIP LIMITED26. Feb. 199726. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BIG HOUSE CONSULTING LIMITED26. Feb. 199726. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    SUNFLOWER PRIVATE NURSERY LIMITED26. Feb. 199726. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    ACCORD TECHNICAL SERVICES LTD.26. Feb. 199726. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    FIFF LIMITED26. Feb. 199726. Feb. 1997LiquidationBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    TURNER POWER SYSTEMS LIMITED25. Feb. 199725. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    W & T OSLER LIMITED25. Feb. 199725. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BM LANDHOLDINGS LIMITED06. Feb. 199725. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    GALLOWAY BUILDING SERVICES LIMITED25. Feb. 199725. Feb. 1997LiquidationBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    MARPET FABRICATIONS (1997) LTD.21. Feb. 199721. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    GLENACRE MANAGEMENT LIMITED21. Feb. 199721. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    BULLDALE MANAGEMENT LIMITED21. Feb. 199721. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    MARINE DIESEL SERVICES (SCOTLAND) LTD21. Feb. 199721. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    CANONGATE DEVELOPMENTS LIMITED02. Jan. 199721. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    ALBA HEALTH LIMITED21. Feb. 199721. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    HEXHAM MANAGEMENT LIMITED21. Feb. 199721. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    CALGREY LIMITED21. Feb. 199721. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    VICTORIAS (LICENCE) LIMITED21. Feb. 199721. Feb. 1997AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish
    TEMPLE HOUSE CARE HOME LIMITED20. Feb. 199720. Feb. 1997AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    ScotlandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0