Stephen MABBOTT - Seite 43
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Stephen |
Nachname | MABBOTT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 2448 |
Gesamt | 2449 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JINTY'S LIMITED | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ONE GOOD IDEA LIMITED | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
KIN AND CARTA SCOTLAND LIMITED | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
A & D KENNEDY QUALITY PROVISIONS LTD. | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GREENLINE MANAGEMENT LIMITED | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SUB-ATLANTIC LIMITED | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
EXTRA ACCESS LIMITED | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
H & I LIVESTOCK LTD. | 20. Feb. 1997 | 20. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DUNEARN PROPERTIES LIMITED | 19. Feb. 1997 | 19. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BEITH GLASS (LANDFILL) LIMITED | 19. Feb. 1997 | 19. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
THE KILT CENTRE LIMITED | 19. Feb. 1997 | 19. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ANCHOR FREIGHT LIMITED | 18. Feb. 1997 | 18. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
VISAGE BEAUTY & TANNING STUDIOS LTD. | 18. Feb. 1997 | 18. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SKIOS INFORMATION MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | 17. Feb. 1997 | 17. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GEMCROSS PROPERTIES LIMITED | 14. Feb. 1997 | 14. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BLOCK, GREY AND BLOCK LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CENTRAL DEMOLITION LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
NAIRN COMMUNITY & ARTS CENTRE | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
K M GEOSCIENCE LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
KIRKTON FARMS LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SOUTHERN PLUMBING & HEATING LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
INVERHEATH LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SPORTS CONNECTION LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
PHOENIX (KIRKCALDY) LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
RANGEFIELD LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
PHOENIX TERTIUM LIMITED | 12. Feb. 1997 | 12. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
LINKFLEET LIMITED | 08. Nov. 1996 | 12. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BEST CELLARS (SCOTLAND) LTD. | 11. Feb. 1997 | 11. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ANNEXE THEATRE PRODUCTIONS | 11. Feb. 1997 | 11. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ALGOA ENGINEERING SERVICES LIMITED | 11. Feb. 1997 | 11. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SD BUSINESS SOLUTIONS LTD | 10. Feb. 1997 | 10. Feb. 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
FM DEVELOPMENTS LTD. | 10. Feb. 1997 | 10. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
PHOENIX KIA LIMITED | 07. Feb. 1997 | 07. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
PHOENIX MOTOWN LIMITED | 07. Feb. 1997 | 07. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
PHOENIX PHAST PHIT LIMITED | 07. Feb. 1997 | 07. Feb. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British |
Zurück2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0