Stephen MABBOTT - Seite 64
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Stephen |
Nachname | MABBOTT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 2448 |
Gesamt | 2449 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROADMEADOW DEVELOPMENTS LTD. | 21. Feb. 1995 | 21. Feb. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
LONGSTONE AUTO SERVICES LTD. | 15. Feb. 1995 | 15. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DIRECT LINE TIMBER LTD. | 14. Feb. 1995 | 14. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
PRIME FABRICATIONS LIMITED | 10. Feb. 1995 | 10. Feb. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
A.B. 2000 LTD. | 07. Feb. 1995 | 07. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
EAGLEBAY LIMITED | 07. Feb. 1995 | 07. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BELLMILL (SCOTLAND) LIMITED | 23. Nov. 1994 | 06. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
THISTLE INNOVATION LTD. | 06. Feb. 1995 | 06. Feb. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HOUSTON WAREHOUSING LIMITED | 03. Feb. 1995 | 03. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
L.J.S. PROPERTIES LTD. | 02. Feb. 1995 | 02. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
EUROPE INVESTMENTS LIMITED | 01. Feb. 1995 | 01. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ROSS AGRI SERVICES LIMITED | 21. Nov. 1994 | 01. Feb. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
W D SHELF LIMITED | 01. Feb. 1995 | 01. Feb. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ABERDEEN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LTD. | 30. Jan. 1995 | 30. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
EAGLE LEASING LIMITED | 30. Jan. 1995 | 30. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CAIRNLOCH LIMITED | 30. Jan. 1995 | 30. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
WAVES RADIO LIMITED | 30. Jan. 1995 | 30. Jan. 1995 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
RELIABILITY ENGINEERING LTD. | 26. Jan. 1995 | 26. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
JOHN A. JACK CONTRACTS LIMITED | 24. Jan. 1995 | 25. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
STRATHCLYDE CLEANING SERVICES LIMITED | 20. Jan. 1995 | 20. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
LARNACH ENGINEERING LIMITED | 20. Jan. 1995 | 20. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
B. AND H. WILLS LTD. | 17. Jan. 1995 | 17. Jan. 1995 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
A1 MINIBUS & COACH SERVICES LTD. | 13. Jan. 1995 | 13. Jan. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
PETER GRAEME LIMITED | 10. Jan. 1995 | 10. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DYSART PROPERTIES LIMITED | 10. Jan. 1995 | 10. Jan. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
JAMES STREET CASH & CARRY LTD. | 05. Jan. 1995 | 05. Jan. 1995 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
KLENCON SERVICES LTD. | 30. Dez. 1994 | 30. Dez. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ROSSFORD LIMITED | 19. Dez. 1994 | 30. Dez. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HAZEL SHIPPING LTD. | 01. Dez. 1994 | 30. Dez. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD. | 28. Dez. 1994 | 28. Dez. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DEEP RIVER (ENGINEERING) LIMITED | 28. Dez. 1994 | 28. Dez. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GARIOCH SPORTS CENTRE (INVERURIE) LIMITED | 28. Dez. 1994 | 28. Dez. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DATAGEN LIMITED | 21. Dez. 1994 | 21. Dez. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HB (1995) LIMITED | 20. Dez. 1994 | 20. Dez. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
IGNITE SCOTLAND LIMITED | 20. Dez. 1994 | 20. Dez. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British |
Zurück2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0