Stephen MABBOTT - Seite 58
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Stephen |
Nachname | MABBOTT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 2448 |
Gesamt | 2449 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB (VENTURES) LIMITED | 19. Feb. 1996 | 19. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
MCCOLL'S TRAVEL LIMITED | 12. Feb. 1996 | 12. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
THE CALEDONIAN OYSTER COMPANY LIMITED | 09. Feb. 1996 | 09. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
STRIKES HOLDINGS LIMITED | 08. Feb. 1996 | 08. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
THISTLE MEAT SPECIALISTS LIMITED | 08. Feb. 1996 | 08. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
LINTHILL LIMITED | 07. Feb. 1996 | 07. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ROCABARRA LTD. | 07. Feb. 1996 | 07. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ITEC INTEGRATIONS (1998) LIMITED | 06. Feb. 1996 | 06. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
PINOCCHIO'S NURSERY LIMITED | 06. Feb. 1996 | 06. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
P & B BUILDERS (SCOTLAND) LIMITED | 06. Feb. 1996 | 06. Feb. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SURESERVE COMPLIANCE NORTH LIMITED | 02. Feb. 1996 | 02. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
GAUGHAN BUILDERS LIMITED | 01. Feb. 1996 | 01. Feb. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HAWK FARMING LIMITED | 30. Jan. 1996 | 30. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HEADLAND GROUP LIMITED | 30. Jan. 1996 | 30. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
EBBA SERVICES LIMITED | 29. Jan. 1996 | 29. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
STRATHMORE ASSETS LIMITED | 29. Jan. 1996 | 29. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SCOTHOPE LIMITED | 14. Nov. 1995 | 29. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ACREPOINT LIMITED | 26. Jan. 1996 | 26. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
INTEGRAL SAFETY LIMITED | 26. Jan. 1996 | 26. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
DEVON ALES LIMITED | 25. Jan. 1996 | 25. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
CRAIGLEITH ELECTRONICS LIMITED | 18. Jan. 1996 | 18. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
TECHNICAL PROGRESS LIMITED | 16. Jan. 1996 | 16. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
TECHNICAL ACTION LIMITED | 16. Jan. 1996 | 16. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SALTIRE MANAGEMENT LIMITED | 07. Jan. 1996 | 16. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
HAGAN PROPERTIES LTD. | 12. Jan. 1996 | 12. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
BALFOUR MUIR ASSOCIATES LIMITED | 11. Jan. 1996 | 11. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
R. SMITH ELECTRICAL CONTRACTORS LTD. | 11. Jan. 1996 | 11. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
MILLERSOFT LIMITED | 09. Jan. 1996 | 09. Jan. 1996 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
STRATHLEA LIMITED | 05. Jan. 1996 | 05. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
EASTMOUNT LIMITED | 04. Jan. 1996 | 04. Jan. 1996 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
MAXWELL FARMS LIMITED | 29. Dez. 1995 | 29. Dez. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
NATUREBOUND LIMITED | 29. Dez. 1995 | 29. Dez. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
OSPREY HOLIDAYS (TICKETS) LIMITED | 28. Dez. 1995 | 28. Dez. 1995 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
SCOTTISH AGRONOMY RESEARCH LIMITED | 28. Dez. 1995 | 28. Dez. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | |
ASHWOOD CONSULTANTS (SCOTLAND) LTD. | 19. Dez. 1995 | 19. Dez. 1995 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British |
Zurück2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0