Lesley Joyce GRAEME - Seite 91
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Lesley |
Zweites Vornamen | Joyce |
Nachname | GRAEME |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 9881 |
Gesamt | 9881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRA SEAFOODS LIMITED | 26. Nov. 2002 | 26. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WRN PROPERTIES LIMITED | 26. Nov. 2002 | 26. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RAMBLA NURSING HOME LIMITED | 26. Nov. 2002 | 26. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
JUDD'S GARAGE LIMITED | 26. Nov. 2002 | 26. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SUB TWO LEISURE LIMITED | 26. Nov. 2002 | 26. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BEST MARKS LIMITED | 26. Nov. 2002 | 26. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ADEVA LIMITED | 13. Sept. 2002 | 26. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COUNTRY STORE HEALTH FOOD LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EDWARDS & TODD LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ADP PRECISION ENGINEERING LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SNAGGING INSPECTIONS LIMITED | 31. Okt. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FOSTELLIS LIMITED | 30. Okt. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SOLUTIONS PUBLISH LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SKIPPERS (FILEY) LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BISK UK LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NEIL DAWSON LANDSCAPING LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
D.H. NEWMAN BUILDERS LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CAR MEDIC (BRIDLINGTON) LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SIMAX CONTRACTING LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOWN & COUNTRY DRIVING SCHOOL LIMITED | 25. Nov. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KINGSLEY FINANCIAL PLANNING LIMITED | 13. Sept. 2002 | 25. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CROWN HIGHWAYS LIMITED | 22. Nov. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PEOPLE AND ORGANISATION DEVELOPMENT LIMITED | 22. Nov. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CASTLE BEDROOMS LIMITED | 22. Nov. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SCARBOROUGH SNOOKER CENTRE LIMITED | 22. Nov. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A. & H. (ROCHESTER) LIMITED | 22. Nov. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HARRITON MECHANICAL ENGINEERING LIMITED | 22. Nov. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PHUNKI LIMITED | 22. Nov. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AARON P STONE (STROOD) LIMITED | 22. Nov. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TCA (UK) LIMITED | 06. Sept. 2002 | 22. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CAPTAIN'S CABIN SEVENOAKS LIMITED | 21. Nov. 2002 | 21. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CHAPPLINS ESTATE AGENTS (HAVANT) LIMITED | 21. Nov. 2002 | 21. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PITHERS PROPERTIES LIMITED | 21. Nov. 2002 | 21. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EFAFLEX UK LIMITED | 21. Nov. 2002 | 21. Nov. 2002 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
H.A. PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 21. Nov. 2002 | 21. Nov. 2002 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0