Lesley Joyce GRAEME - Seite 81
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Lesley |
Zweites Vornamen | Joyce |
Nachname | GRAEME |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 9881 |
Gesamt | 9881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER HILLS DAIRIES (ERITH) LIMITED | 12. Feb. 2003 | 12. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HOOLECORP LIMITED | 12. Feb. 2003 | 12. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STARPOUND LIMITED | 23. Dez. 2002 | 12. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE MANAGEMENT CENTRE (UK) LIMITED | 11. Feb. 2003 | 11. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S.H. BUILDING & CARPENTRY LIMITED | 11. Feb. 2003 | 11. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STEVEN J. DUNN & ASSOCIATES LIMITED | 11. Feb. 2003 | 11. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CAROLE NEWMAN INTERIORS LIMITED | 11. Feb. 2003 | 11. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ADAMS UK. LTD | 11. Feb. 2003 | 11. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SECOND WAVE CONSULTING LIMITED | 11. Feb. 2003 | 11. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LAKEHURST INVESTMENTS LIMITED | 07. Feb. 2003 | 07. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BROSNANS LIMITED | 07. Feb. 2003 | 07. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CELL PROJECTS LIMITED | 17. Dez. 2002 | 07. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRYN HAWKINS DAIRIES (DEAL) LIMITED | 07. Feb. 2003 | 07. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BOATHOUSE MAINTENANCE LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RUSSELL HAINES LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BADIAL RETAIL LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HRP SERVICES LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
VALLEYVIEW ASSOCIATES LIMITED | 14. Jan. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PIPKIN PROPERTIES LIMITED | 06. Jan. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROBINSCROFT LTD. | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EQUIPMENT SUPPLY SERVICES LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GRAYBROWNE LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CAPITAL TRAINING SERVICES LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BASFORD ENTERPRISES | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TUDOR BRICKWORK & BUILDING LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A BROOKER LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRICERITE WINDOWS (SOUTH EAST) LIMITED | 06. Feb. 2003 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALL YEAR ROUND TRADING LIMITED | 23. Dez. 2002 | 06. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GATELAND (NORTH EAST) LIMITED | 05. Feb. 2003 | 05. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ELENDER PROPERTIES LTD | 20. Dez. 2002 | 04. Feb. 2003 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SHADES OF GREEN GARDEN CENTRE LIMITED | 04. Feb. 2003 | 04. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
N.W. BINKS LIMITED | 04. Feb. 2003 | 04. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PELA SOLUTIONS DESIGN LIMITED | 04. Feb. 2003 | 04. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EUROSIRE PUBLICATIONS LIMITED | 04. Feb. 2003 | 04. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J T BUILDING CONTRACTORS LIMITED | 04. Feb. 2003 | 04. Feb. 2003 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0