Lesley Joyce GRAEME - Seite 13
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Lesley |
Zweites Vornamen | Joyce |
Nachname | GRAEME |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 9881 |
Gesamt | 9881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 NINES DATA CENTRES LIMITED | 23. Sept. 2004 | 23. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BROADWAY COMMUNICATIONS NORTH EAST LIMITED | 23. Sept. 2004 | 23. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GMS INTERIOR SERVICES LIMITED | 23. Sept. 2004 | 23. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CUBRITZ LIMITED | 23. Sept. 2004 | 23. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THANET WATERCOOLER DELIVERY COMPANY LIMITED | 23. Sept. 2004 | 23. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
S W GLASS (MIDLAND) LIMITED | 21. Sept. 2004 | 21. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
G & A INTERIORS LIMITED | 21. Sept. 2004 | 21. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALPHA STORAGE LIMITED | 21. Sept. 2004 | 21. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
P DALTON ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED | 17. Sept. 2004 | 17. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WIZARD CLEANING LIMITED | 17. Sept. 2004 | 17. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
UPLANDS ENGINEERING LIMITED | 17. Sept. 2004 | 17. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FAULKNER PLANT SERVICES LIMITED | 17. Sept. 2004 | 17. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THE FILING COMPANY LIMITED | 17. Sept. 2004 | 17. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MAXIM DISPLAY LIMITED | 17. Sept. 2004 | 17. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
21C CONTRACTORS LIMITED | 17. Sept. 2004 | 17. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
E.G. LEWIS DEVELOPMENTS LIMITED | 16. Sept. 2004 | 16. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALL TERRAIN GROUND WORKS LIMITED | 16. Sept. 2004 | 16. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HOME RECYCLING LIMITED | 15. Sept. 2004 | 15. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLUBHOUSE HOLDINGS LIMITED | 27. Juli 2004 | 15. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TTL TEMP CO LIMITED | 15. Sept. 2004 | 15. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ENGINEERING & MORE LIMITED | 15. Sept. 2004 | 15. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ILK SHELF COMPANY LIMITED | 15. Sept. 2004 | 15. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CONTINENTAL SNACKS LIMITED | 15. Sept. 2004 | 15. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SYLTONS DEVELOPMENTS LTD | 14. Sept. 2004 | 14. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STARSTYLE STUDIOS LIMITED | 14. Sept. 2004 | 14. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
L C BYNE & SON LIMITED | 13. Sept. 2004 | 13. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CP BUILDING SYSTEMS LTD | 13. Sept. 2004 | 13. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
QUALITY RESTAURANTS (UK) LIMITED | 13. Sept. 2004 | 13. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TOURAINE VACANCES COTTAGES LIMITED | 15. Apr. 2004 | 13. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GLEBE BUSINESS PARK LIMITED | 10. Sept. 2004 | 10. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EAST STREET HUNTINGDON MANAGEMENT CO. LIMITED | 10. Sept. 2004 | 10. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HFS ENVIRONMENTAL LIMITED | 12. Aug. 2004 | 10. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CALMA BARS LIMITED | 08. Sept. 2004 | 08. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KNOWN LIMITED | 07. Sept. 2004 | 07. Sept. 2004 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HVH (CHESHIRE) LIMITED | 08. Apr. 2004 | 06. Sept. 2004 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0