Lesley Joyce GRAEME - Seite 258
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Lesley |
Zweites Vornamen | Joyce |
Nachname | GRAEME |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 9881 |
Gesamt | 9881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGLINK LIMITED | 30. Sept. 1994 | 30. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
APOLLO PLASTIC SYSTEMS LIMITED | 28. Sept. 1994 | 28. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HEATHCOTEPLACE LIMITED | 15. Aug. 1994 | 28. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
MAX LOGICS LIMITED | 26. Sept. 1994 | 26. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DARWINGROVE LIMITED | 18. Aug. 1994 | 26. Sept. 1994 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GROSVENORMOUNT LIMITED | 05. Sept. 1994 | 23. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PJW CONSULTING SERVICES LIMITED | 19. Sept. 1994 | 19. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NG INNS LIMITED | 20. Juni 1994 | 19. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
KENT DUCTWORK LIMITED | 16. Aug. 1994 | 16. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CARELINK COMMUNITY SERVICES LIMITED | 16. Sept. 1994 | 16. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BROWN MCLEOD LIMITED | 19. Juli 1994 | 15. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BENTICO LIMITED | 05. Sept. 1994 | 13. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
RUBYESTATES LIMITED | 21. Juli 1994 | 13. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AGE UK NORTHAMPTONSHIRE TRADING LIMITED | 09. Sept. 1994 | 09. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AUDIO TECHNOLOGY (INTERNATIONAL) LIMITED | 09. Sept. 1994 | 09. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NORTH EAST RACING (ONE) LIMITED | 05. Aug. 1994 | 09. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NORTH EAST RACING (FIVE) LIMITED | 08. Juli 1994 | 09. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
NORTH EAST RACING (FOUR) LIMITED | 10. Juni 1994 | 09. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BRUNELHOMES LIMITED | 18. Juli 1994 | 08. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PREMIER DIAMOND PRODUCTS LIMITED | 07. Sept. 1994 | 07. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PASTY PRESTO LIMITED | 05. Sept. 1994 | 05. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
EUROGUARD PEST CONTROL LIMITED | 02. Sept. 1994 | 02. Sept. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRIOR CONSULTATION LIMITED | 02. Sept. 1994 | 02. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CALANGE LIMITED | 02. Sept. 1994 | 02. Sept. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SHIPMANAGEMENT TRADING LIMITED | 31. Aug. 1994 | 31. Aug. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
R. KELSALL COMPUTING LIMITED | 30. Aug. 1994 | 30. Aug. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HOT PROPERTY LIMITED | 30. Aug. 1994 | 30. Aug. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ARMADATECH LIMITED | 22. Aug. 1994 | 30. Aug. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BARTWOOD LIMITED | 22. Aug. 1994 | 26. Aug. 1994 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GRAMERCI LIMITED | 25. Aug. 1994 | 25. Aug. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GORDON CONTRACT SERVICES LTD | 25. Aug. 1994 | 25. Aug. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DONSONS LIMITED | 15. Juli 1994 | 22. Aug. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
BABY POINT LIMITED | 19. Aug. 1994 | 19. Aug. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SKEWEN POULTRY LIMITED | 18. Aug. 1994 | 18. Aug. 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ELLENRIDGE LIMITED | 15. Aug. 1994 | 17. Aug. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0