Lesley Joyce GRAEME - Seite 134
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Lesley |
Zweites Vornamen | Joyce |
Nachname | GRAEME |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 9881 |
Gesamt | 9881 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICTURE LANGUAGE LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
J & D SHEPHERD LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GEOFF HARRIS LOGISTICS LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SIMON FRITH BUILDING CONTRACTORS LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
TDB MANAGEMENT LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
COLIN APPLEBY LIMITED | 20. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HEARTSWELL (MAIDSTONE) LTD | 10. Sept. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ORCHARDVIEW PROPERTIES LIMITED | 30. Aug. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ODYSSEY ESTATES LIMITED | 01. Aug. 2001 | 20. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ROGUE GENE ADVERTISING LIMITED | 19. Sept. 2001 | 19. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AVAILABILITY SYSTEMS LIMITED | 19. Sept. 2001 | 19. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
A.F. INSPECTIONS & SAFETY LIMITED | 19. Sept. 2001 | 19. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CLIFFE WOODS GARAGE LIMITED | 18. Sept. 2001 | 18. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
THOMPSON CONSULTING SERVICES LIMITED | 17. Sept. 2001 | 17. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LE CHATEAU LIMITED | 09. Aug. 2001 | 14. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
PRIME GROUP LIMITED | 13. Sept. 2001 | 13. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STUDIO 808 LIMITED | 13. Sept. 2001 | 13. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HORSES R US LIMITED | 13. Sept. 2001 | 13. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
CREDFELD ENGINEERING LIMITED | 13. Sept. 2001 | 13. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
QUARTZ CATERING LIMITED | 08. Aug. 2001 | 13. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
LOGS AND FUEL LTD | 01. Aug. 2001 | 12. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
AMBERDELIGHT LIMITED | 17. Juli 2001 | 12. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HARRISON DEVELOPMENTS (UK) LIMITED | 11. Sept. 2001 | 11. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
STEVE MARSH DESIGN LIMITED | 27. Juni 2001 | 11. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ALAN CHAPMAN MANAGEMENT LIMITED | 11. Sept. 2001 | 11. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
ZI (UK) LIMITED | 30. Aug. 2001 | 11. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
WHITE ROSE INSURANCE SOLUTIONS LTD | 10. Sept. 2001 | 10. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DENTAL X-RAYS AND IMAGING LIMITED | 10. Sept. 2001 | 10. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
GROUP BUSINESS SERVICES LIMITED | 22. Juni 2001 | 10. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
APULIA LIMITED | 22. Juni 2001 | 07. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
DEVONSHIRE-WILSON LIMITED | 07. Sept. 2001 | 07. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
SQUARE GREEN LIMITED | 07. Sept. 2001 | 07. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
K PATRICK & COMPANY LIMITED | 14. Juni 2001 | 06. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
HERBS PLUS DIRECT LIMITED | 05. Sept. 2001 | 05. Sept. 2001 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | ||
FORMATTING TELEVISION LIMITED | 05. Sept. 2001 | 05. Sept. 2001 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0