Michael Sheldon SILVERSTONE
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | Michael |
Zweites Vornamen | Sheldon |
Nachname | SILVERSTONE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 441 |
Gesamt | 441 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELFORD LTD | 28. Juli 1998 | 15. Sept. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
QUARTET SOLUTIONS LIMITED | 09. Sept. 1998 | 09. Sept. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
COLORLAB LTD | 07. Sept. 1998 | 07. Sept. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
GOWER DESIGN LTD | 04. Sept. 1998 | 04. Sept. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
SANTOSHA LTD | 01. Sept. 1998 | 01. Sept. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
THE ARTMASTER GALLERY LTD | 28. Aug. 1998 | 28. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
BVISUAL LTD | 25. Aug. 1998 | 25. Aug. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MCDAID BARROW LTD | 25. Aug. 1998 | 25. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ACUMEN CONSULTANTS LIMITED | 21. Aug. 1998 | 21. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CLAREMONT REST HOME LIMITED | 21. Aug. 1998 | 21. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
HART CONTROL SYSTEMS LIMITED | 20. Aug. 1998 | 20. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
GHAUSIA CONSTRUCTION LTD | 20. Aug. 1998 | 20. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
COXLEY SOFTWARE LIMITED | 19. Aug. 1998 | 19. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MOTOR CORNER CAR SALES LIMITED | 19. Aug. 1998 | 19. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
D3 CREATIVE LIMITED | 14. Aug. 1998 | 14. Aug. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
RWS DRUMS & PERCUSSION LIMITED | 13. Aug. 1998 | 13. Aug. 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
YNM PROPERTIES LTD | 06. Aug. 1998 | 06. Aug. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
GO FREEDIVING LIMITED | 05. Aug. 1998 | 05. Aug. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
KEYN LOGISTICS MANAGEMENT LIMITED | 23. Juli 1998 | 01. Aug. 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MEDSHAM LTD | 28. Juli 1998 | 28. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
RELAY GROUP LTD | 28. Juli 1998 | 28. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
CLEAR DIRECTIONS LIMITED | 24. Juli 1998 | 28. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
THE MOUNTAIN SPRING WATER COMPANY LTD | 24. Juli 1998 | 24. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
BROOMHILL PROPERTIES LTD | 22. Juli 1998 | 22. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
JR & B SELDON LTD | 21. Juli 1998 | 21. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
INDEPENDENT ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED | 21. Juli 1998 | 21. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
O'CONNOR PROPERTIES LTD | 21. Juli 1998 | 21. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
FIVE STAR ESTATES LTD | 15. Juli 1998 | 17. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
MARKETING FOR PROFITS LTD | 15. Juli 1998 | 15. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ORPHEUS CONSULTANTS LIMITED | 15. Juli 1998 | 15. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
PARTNER TO PARTNER LTD | 15. Juli 1998 | 15. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
WAVENEY ELECTRICAL SERVICES LTD | 15. Juli 1998 | 15. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
ZECOL LIMITED | 13. Juli 1998 | 13. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
N.J.W. DEVELOPMENTS RESTORED 2020 LIMITED | 13. Juli 1998 | 13. Juli 1998 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British | ||
RACHEL ROBERTS LIMITED | 08. Juli 1998 | 08. Juli 1998 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 65 Stanley Road M7 4GT Salford Lancashire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0