Michael Sheldon SILVERSTONE
  • Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Michael Sheldon SILVERSTONE - Seite 10

    Natürliche Person

    Titel
    VornameMichael
    Zweites VornamenSheldon
    NachnameSILVERSTONE
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv0
    Zurückgetreten441
    Gesamt441

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    HOMER PHOENIX MANAGEMENT LIMITED01. März 199502. März 1995AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    BROOKLEIGH CONSTRUCTION LIMITED28. Feb. 199501. März 1995AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    DALE CONSULTING LIMITED28. Feb. 199501. März 1995AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    HOLMEFIELD LTD23. Feb. 199527. Feb. 1995AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    UNO OUTFITTERS LTD17. Feb. 199520. Feb. 1995AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CONQUEROR RACING LTD17. Feb. 199520. Feb. 1995AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    ASHTEAD COTTAGE LIMITED02. Feb. 199520. Feb. 1995AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    ABBOTSFORD LTD15. Feb. 199517. Feb. 1995LiquidationBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    PETER LOWE CONSTRUCTION LTD01. Feb. 199502. Feb. 1995AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    INFORMATION TECHNOLOGY DELIVERY BUSINESS LTD26. Jan. 199501. Feb. 1995AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    INTARIDE LIMITED27. Jan. 199530. Jan. 1995AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CROWN POPS LIMITED13. Jan. 199516. Jan. 1995AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    COTSWOLD SAFETY CONSULTANCY LTD09. Jan. 199510. Jan. 1995AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    P.K.F. LTD06. Jan. 199509. Jan. 1995AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    INTERACTIVE RACING LTD06. Jan. 199509. Jan. 1995AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    RTE LTD23. Dez. 199428. Dez. 1994LiquidationBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    THORPES BUILDING SUPPLIES LIMITED21. Dez. 199422. Dez. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CELIA ADAMS ASSOCIATES LTD21. Dez. 199422. Dez. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    W P I SURFACING LIMITED15. Dez. 199416. Dez. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    DEVON MINOR WORKS CONTRACTOR LTD15. Dez. 199416. Dez. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    THE ACADEMY OF DIGITAL MUSIC LTD15. Dez. 199416. Dez. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    HC VEHICLES LTD15. Dez. 199416. Dez. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    KIDDLE WEST MARTIN & CO. LTD.06. Dez. 199407. Dez. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    HILLSIDE MANAGEMENT SERVICES LIMITED01. Dez. 199402. Dez. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    WILLOWFOLD LTD28. Nov. 199402. Dez. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CHESHIRE WORKSHOPS LTD18. Nov. 199421. Nov. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    EAST MIDLANDS WATER COMPANY (SOUTH EAST) LTD17. Nov. 199418. Nov. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    DEEPDALE SOLUTIONS LTD07. Nov. 199417. Nov. 1994LiquidationBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    RAM IT LIMITED15. Nov. 199416. Nov. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    ECODYNAMICS LIMITED08. Nov. 199409. Nov. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    FORTHVIEW LTD17. Okt. 199427. Okt. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    SOUTHLINK METAL FABRICATIONS LTD24. Okt. 199425. Okt. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    PATTINSON ACCOUNTING SERVICES LIMITED17. Okt. 199424. Okt. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    CREATIV PROPERTY LIMITED18. Okt. 199419. Okt. 1994AufgelöstBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British
    HYBRID CONSULTING LTD18. Okt. 199419. Okt. 1994AktivBevollmächtigter Geschäftsführer
    65 Stanley Road
    M7 4GT Salford
    Lancashire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0